CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED

CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03805091
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ACRE 310 LIMITED12. Juli 199912. Juli 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Thomas Liam O'donohoe als Geschäftsführer am 21. Sept. 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark William Fitzgerald als Geschäftsführer am 21. Sept. 2022

    1 SeitenTM01

    Cessation of Cherry Rose Investments Limited as a person with significant control on 22. Sept. 2022

    1 SeitenPSC07

    Notification of Steven Mark Aldridge as a person with significant control on 22. Sept. 2022

    2 SeitenPSC01

    Cessation of Thomas Liam O'donohoe as a person with significant control on 22. Sept. 2022

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Juli 2021

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Steven Mark Aldridge am 19. Juli 2021

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Juli 2020

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Juli 2019

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Juli 2018

    7 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Steven Mark Aldridge am 18. März 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Steven Mark Aldridge am 18. März 2019

    2 SeitenCH01

    Change of details for Thomas Liam O'donohoe as a person with significant control on 20. Nov. 2018

    2 SeitenPSC04

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Juli 2017

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 08. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    9 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2016

    10 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALDRIDGE, Steven Mark
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    Geschäftsführer
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    EnglandBritish67139430012
    GRAF, Robin Anthony Scott
    16 Elwill Way
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    Sekretär
    16 Elwill Way
    BR3 3AD Beckenham
    Kent
    British3942820001
    WRIGHT, Sunchia Liza
    73e Warrington Crescent
    W9 1EH London
    Sekretär
    73e Warrington Crescent
    W9 1EH London
    British67139500001
    LAWSON (LONDON) LIMITED
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    900018120001
    CLAYDON, Katherine Maria
    20 Lambourne Gardens
    Chingford
    E4 7SG London
    Geschäftsführer
    20 Lambourne Gardens
    Chingford
    E4 7SG London
    EnglandBritish58204010001
    COOPER, Michael Edward
    23 Priory Road
    N8 8LH London
    Geschäftsführer
    23 Priory Road
    N8 8LH London
    British64658610001
    FITZGERALD, Mark William
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    EnglandBritish154379460003
    O'DONOHOE, Thomas Liam
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    United KingdomIrish158163190002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Steven Mark Aldridge
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    22. Sept. 2022
    Acre House 11-15 William Road
    London
    NW1 3ER
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Thomas Liam O'Donohoe
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Ja
    Nationalität: Irish
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer07509939
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer07995579
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat CITYSCOPE DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Interest loan agreement
    Erstellt am 31. Mai 2012
    Geliefert am 23. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,400,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge property k/a 44 jubilee place london t/no NGL623096 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Easter Rose Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    Interest loan agreement
    Erstellt am 31. Mai 2012
    Geliefert am 23. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,400,000 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge property k/a 44 jubilee place london t/no NGL623096 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Cherry Rose Investments Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    Interest free loan agreement
    Erstellt am 31. Mai 2012
    Geliefert am 23. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £878,665 due or to become due from the company to the charge on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge property k/a 44 jubilee place london t/no NGL623096 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Easter Rose Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    Interest free loan agreement
    Erstellt am 31. Mai 2012
    Geliefert am 23. Jan. 2013
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £878,665 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge 44 jubilee place london t/no NGL623096 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Cherry Rose Investments Limited
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 2006
    Geliefert am 01. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    32, hesper mews, london t/no LN109874. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Nov. 2005
    Geliefert am 24. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    29 malvern court onslow square london t/no BGL44805. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 2005
    Geliefert am 19. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of charge
    Erstellt am 23. Juli 2004
    Geliefert am 31. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 2, 7/8 sydney place kensington london fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans Limited
    Transaktionen
    • 31. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Jan. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as flat d 48 redcliffe gardens london SW10 9HB.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Jan. 2003
    Geliefert am 15. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £260,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 48D redcliffe gardens london t/n BGL35642.
    Berechtigte Personen
    • Redcliffe Estates Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 02. Jan. 2003
    Geliefert am 08. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Okt. 2002
    Geliefert am 12. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as basement flat 7 ormonde gate chelsea london SW3 4EU. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Apr. 2002
    Geliefert am 01. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 2,7 sydney place,london SW7 3NL. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 2001
    Geliefert am 02. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a flat e, 40 lexham gardens, kensington, london W8 5JE.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Mai 2000
    Geliefert am 08. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 14 h randolph crescent london t/no: NGL464430. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Jan. 2000
    Geliefert am 25. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 28 castellain mansions castellain road london t/n-NGL707987. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0