THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03805229 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED?
- Einzelhandel mit Kraftstoffen in spezialisierten Geschäften (47300) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Euro House Haslingden Road BB1 2EE Blackburn England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PENTCOL LIMITED | 12. Juli 1999 | 12. Juli 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 16. Feb. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 04. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Tdr Capital General Partner Iii Limited as a person with significant control on 30. Juni 2017 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Notification of Optima Bidco (Jersey) Limited as a person with significant control on 30. Juni 2017 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Notification of Zuber Vali Issa as a person with significant control on 30. Juni 2017 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Notification of Mohsin Issa as a person with significant control on 30. Juni 2017 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Cessation of Euro Garages Limited as a person with significant control on 30. Juni 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 15. Feb. 2019 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 16. Feb. 2018 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Sept. 2018 bis 16. Feb. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 45 High Street Haverfordwest Pembroke SA61 2BP zum Euro House Haslingden Road Blackburn BB1 2EE am 09. Juli 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Euro House the Beehive Trading Park Haslingden Road Blackburn BB1 2EE England zum 45 High Street Haverfordwest Pembroke SA61 2BP am 08. März 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2017 bis 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Intervias Finco Limited as a person with significant control on 30. Juni 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Cessation of The Orchard Group Limited as a person with significant control on 22. Juni 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Change of details for The Orchard Group Limited as a person with significant control on 22. Juni 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Helen Pettit als Sekretär am 22. Juni 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Arthur Pettit als Geschäftsführer am 22. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSA, Mohsin | Geschäftsführer | Haslingden Road BB1 2EE Blackburn Euro House England | England | British | 204756380001 | |||||
| ISSA, Zuber Vali | Geschäftsführer | Haslingden Road BB1 2EE Blackburn Euro House England | United Kingdom | British | 204756370001 | |||||
| KEETLEY, Julia Ann | Sekretär | 15 Wingbourne Walk NG6 8DT Nottingham Nottinghamshire | British | 66159680001 | ||||||
| MORGAN, Susan Elizabeth | Sekretär | 22 The Gowans Sutton On The Forest YO61 1DJ York Yorkshire | British | 60797960001 | ||||||
| PETTIT, Helen | Sekretär | Stow Hill NP20 4GA Newport Stow Hill Service Station Gwent United Kingdom | British | 86103380001 | ||||||
| SCOTT, Stephen John | Bevollmächtigter Sekretär | 52 Mucklow Hill Halesowen B62 8BL Birmingham | British | 900002270001 | ||||||
| FRANKLIN, Helen Elizabeth | Geschäftsführer | 3 Pembrey Close Trowell Park NG9 3RW Nottingham Nottinghamshire | British | 37955570001 | ||||||
| PETTIT, Helen Elizabeth | Geschäftsführer | Stow Hill NP20 4GA Newport Stow Hill Service Station Gwent United Kingdom | England | British | 196118460001 | |||||
| PETTIT, Robert Arthur | Geschäftsführer | Stow Hill NP20 4GA Newport Stow Hill Service Station Gwent United Kingdom | United Kingdom | British | 66194730003 | |||||
| SCOTT, Jacqueline | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 52 Mucklow Hill Halesowen B62 8BL Birmingham | British | 900002260001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima Bidco (Jersey) Limited | 30. Juni 2017 | Esplanade St Helier JE1 0BD Jersey 47 Jersey | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Mohsin Issa | 30. Juni 2017 | Haslingden Road BB1 2EE Blackburn Euro House England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Zuber Vali Issa | 30. Juni 2017 | Haslingden Road BB1 2EE Blackburn Euro House England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Tdr Capital General Partner Iii Limited | 30. Juni 2017 | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| The Orchard Group Limited | 22. Juni 2017 | The Beehive Trading Park Haslingden Road BB1 2EE Blackburn Euro House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Euro Garages Limited | 06. Apr. 2016 | Haslingden Road BB1 2EE Blackburn Euro House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mrs Helen Elizabeth Pettit | 06. Apr. 2016 | Stow Hill NP20 4GA Newport Stow Hill Service Station Gwent Wales | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Robert Arthur Pettit | 06. Apr. 2016 | Stow Hill NP20 4GA Newport Stow Hill Service Station Gwent Wales | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 19. Dez. 2002 Geliefert am 07. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as waterton filling station by-pass road bridgend. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 2002 Geliefert am 21. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Dez. 2000 Geliefert am 19. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Waterton filling station by pass road bridgend t/n WA942749. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 20. Nov. 2000 Geliefert am 28. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Nov. 2000 Geliefert am 07. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the charge or otherwise | |
Kurze Angaben The freehold property known as waterton filling station by-pass road bridgend title number WA942749. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. März 2000 Geliefert am 07. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under any agreements and in connection with any loan | |
Kurze Angaben Premises at chequered flag filling station newport road trethomas newport gwent all fixtures and fittings all rental income the proceeds of sale the goodwill of the business and the benefit of all contracts and debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Dez. 1999 Geliefert am 24. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Nov. 1999 Geliefert am 19. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and all other obligations and liabilities now or hereafter due owing or incurred by the company to barclays bank PLC (the "lender") under the offer letter (as defined) or otherwise | |
Kurze Angaben The property comprising waterton filling station bridgend bypass bridgend CF31 3LT, first fixed charge the proceeds of any payment of claims awards or judgements, assigns the goodwill of the business and the benefit of all petroleum and other licences floating charge all wet and dry stock. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit deed | Erstellt am 05. Nov. 1999 Geliefert am 13. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a supply agreement dated 5TH november 1999 | |
Kurze Angaben Deposit account with leeds & holbeck building society in a deposit account in the sum of £60,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat THREE OAKS INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0