IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED

IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameIPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03806722
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Room 5-C19 Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BURSTCAT LIMITED14. Juli 199914. Juli 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 26. Nov. 2009

    • Kapital: GBP 3
    4 SeitenSH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KLEIN, Lauren Ezrol
    40 East 88th Street
    Apartment 6b
    New York
    Ny 10128
    Usa
    Sekretär
    40 East 88th Street
    Apartment 6b
    New York
    Ny 10128
    Usa
    British127397780001
    WILLIAMS, Sally Jane
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Sekretär
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    British3660830002
    AUTON, Sylvia Jean
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59045280002
    AVERILL, Howard
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    Geschäftsführer
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    UsaUsa127283350001
    EVANS, Richard John
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish77303490001
    EVANS, Sylvia Kathleen
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    Geschäftsführer
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    United KingdomNew Zealander70941240001
    WEBSTER, Evelyn Ann
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    Geschäftsführer
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    EnglandBritish68847920003
    GAFFIKIN, Benjamin Thomas Michael
    5 Bromfield Street
    N1 0QA London
    Sekretär
    5 Bromfield Street
    N1 0QA London
    Irish65557730001
    GORE, John Francis
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Sekretär
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British352680001
    MCCARTHY, Robert
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    Sekretär
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    British78644500001
    REDPATH, John
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    Sekretär
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    British88622150001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Geschäftsführer
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    ATKINSON, Richard Gordon
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Geschäftsführer
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    British78644420001
    BAILEY, Sylvia
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    Geschäftsführer
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    British67232740001
    BARKER, David Robert
    60 Woodwarde Road
    Dulwich
    SE22 8UL London
    Geschäftsführer
    60 Woodwarde Road
    Dulwich
    SE22 8UL London
    United KingdomBritish67233910001
    BONDERGAARD, Mads
    Flat 14
    119 Westbourne Terrace
    W2 6QT London
    Geschäftsführer
    Flat 14
    119 Westbourne Terrace
    W2 6QT London
    Danish76502920003
    CARAYOL, Rene Roland
    3 Victoria Rise
    Hilgrove Road
    NW6 4TH Swiss Cottage
    London
    Geschäftsführer
    3 Victoria Rise
    Hilgrove Road
    NW6 4TH Swiss Cottage
    London
    United KingdomBritish155413470001
    GAFFIKIN, Benjamin Thomas Michael
    5 Bromfield Street
    N1 0QA London
    Geschäftsführer
    5 Bromfield Street
    N1 0QA London
    Irish65557730001
    KERRIGAN, Kevin
    Tarn End
    Tarn Road
    GU26 6TP Hindhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Tarn End
    Tarn Road
    GU26 6TP Hindhead
    Surrey
    EnglandIrish67233990001
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Geschäftsführer
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    MATTHEW, Michael
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    Geschäftsführer
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    British40092920001
    ROSEN, Howard Norman
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Geschäftsführer
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    UsaUsa111282190001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat IPC ELECTRIC (SERVICES) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 02. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Aug. 1999
    Geliefert am 02. Sept. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0