TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED

TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03808866
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    • Vorschule (85100) / Erziehung

    Wo befindet sich TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Busy Bees At St Matthews
    Shaftesbury Drive
    WS7 9QP Burntwood
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TLC NEXUS LIMITED16. Dez. 199916. Dez. 1999
    SHELFCO (NO.1717) LIMITED16. Juli 199916. Juli 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Lynn Carol Woodward als Geschäftsführer am 01. Dez. 2012

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Juli 2012

    Kapitalaufstellung am 19. Juli 2012

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    21 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    6 SeitenMG01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 23. Dez. 2010

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account reduced to nil 22/12/2010
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    20 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2009 bis 31. Dez. 2009

    1 SeitenAA01

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    17 Seiten395

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    22 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    2 Seiten88(2)

    Wer sind die Geschäftsführer von TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Sekretär
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    British55976790005
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Geschäftsführer
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritish55976790005
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish9070120002
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritish9070090003
    BAKER, Barbara
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    British58817820002
    BAKER, Barbara
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    British58817820002
    ROBINSON, Richard
    11 The Courtyard
    Stoke Golding
    CV13 6EX Nuneaton
    Warwickshire
    Sekretär
    11 The Courtyard
    Stoke Golding
    CV13 6EX Nuneaton
    Warwickshire
    British107829020001
    STONE, David Michael
    The Paddocks 147 Gillway Lane
    B79 8PN Tamworth
    Staffordshire
    Sekretär
    The Paddocks 147 Gillway Lane
    B79 8PN Tamworth
    Staffordshire
    British57522290001
    TURNER, Nicholas Robert
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    Sekretär
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    British123183150001
    E P S SECRETARIES LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900004930001
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Alexandra House
    Alexandra Terrace
    GU1 3DA Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Alexandra House
    Alexandra Terrace
    GU1 3DA Guildford
    Surrey
    57253330001
    BAKER, Barbara
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Bridge House
    2 Swinnertons Lane Yelvertoft
    NN6 6LS Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish58817820002
    GRIFFIN, Catherine Margaret
    30 Finmere
    CV21 1RT Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    30 Finmere
    CV21 1RT Rugby
    Warwickshire
    British58817810002
    HYMAN, Harry Abraham
    Tara House Cleardown
    The Hockering
    GU22 7HH Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Tara House Cleardown
    The Hockering
    GU22 7HH Woking
    Surrey
    United KingdomBritish35560380001
    KELLY, Bernard Noel David
    72 Piper Buildings
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    Geschäftsführer
    72 Piper Buildings
    Peterborough Road
    SW6 3EF London
    EnglandBritish111133320001
    ROBINSON, Richard
    11 The Courtyard
    Stoke Golding
    CV13 6EX Nuneaton
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    11 The Courtyard
    Stoke Golding
    CV13 6EX Nuneaton
    Warwickshire
    British107829020001
    STONE, David Michael
    The Paddocks 147 Gillway Lane
    B79 8PN Tamworth
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    The Paddocks 147 Gillway Lane
    B79 8PN Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish57522290001
    TEMPLE, John
    3 Victoria Crescent
    Queens Park
    CH4 7AX Chester
    Geschäftsführer
    3 Victoria Crescent
    Queens Park
    CH4 7AX Chester
    British62721620002
    TURNER, Nicholas Robert
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    15 Manor Gardens
    Desford
    LE9 9QB Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish123183150001
    WOODWARD, Lynn Carol
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish3850190004
    MIKJON LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    50 Stratton Street
    W1X 5FL London
    900004920001

    Hat TLC (TENDER LOVING CHILDCARE) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2010
    Geliefert am 30. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 20. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession
    Erstellt am 05. Juni 2009
    Geliefert am 16. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Princess christian college wilbraham road fallowfields manchester. Chester street, aston lock south birmingham, land on the west side of manton lane bedford. For further properties please see form 395 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Okt. 2007
    Geliefert am 19. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A cash sum of £20,362.50 and any additional sums deposited under the terms of the rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Gml Construction Limited
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 10. Okt. 2006
    Geliefert am 19. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All land all the goodwill and uncalled capital the securities the debts and fixed plant and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nexus Structured Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of security of the benefit of a building contract
    Erstellt am 15. Sept. 2004
    Geliefert am 22. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The entire beneficial interest in and benefit to the mortgagor of the building contract dated 29 march 2004.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over development agreement and childcare agreement
    Erstellt am 15. Sept. 2004
    Geliefert am 22. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the benefit of the company's interest the development agreement dated 13TH september 2004 all the benefit of the company's interest in the childcare agreement dated 13TH september 2004,all rights,titles,benefits and interests of the company whatsoever present and future whether proprietary,contractual or otherwise arising out of or connected with or relating to the development agreement and childcare agreement including without limitation all claims for damages in respect of any breach thereof.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Sept. 2004
    Geliefert am 22. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a hillingdon hospital childcare facility,hillingdon hospital,pield heath road,uxbridge. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 2003
    Geliefert am 11. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the l/h property known as child care unit, milton keynes general hospital, milton. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Jan. 2003
    Geliefert am 01. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nexus Structured Finance Limited
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of security of the benefit of a building contract
    Erstellt am 09. Dez. 2002
    Geliefert am 14. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The entire beneficial interest in a building contract dated 31 july 2002.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over agreement for lease
    Erstellt am 09. Dez. 2002
    Geliefert am 14. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the benefit of the company's interest in agreement for lease. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juli 2002
    Geliefert am 18. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land at university park nottingham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Jan. 2002
    Geliefert am 28. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as land at university park, nottingham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Nov. 2001
    Geliefert am 20. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The day care centre nottingham city hospital huchwall road nottingham. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 12. Nov. 2001
    Geliefert am 20. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Policy number 10C51H11 on the life of david stone for the sum assured of £333,000, policy number 91B36B58 on the life of catherine griffin for the sum assured of £500,000 and policy number 91B36X65 on the life of barbara baker for the sum assured of £500,000 all policies are with j rothschild. All sums assured by the policies and all bonuses and benefits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Nov. 2001
    Geliefert am 20. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Nov. 2000
    Geliefert am 13. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murray Vct 3 PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Nov. 2000
    Geliefert am 13. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Murray Vct 4 PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Dez. 1999
    Geliefert am 24. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nexus Structured Finance Limited,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0