MANTANA MARKETING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMANTANA MARKETING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03817437
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MANTANA MARKETING LIMITED?

    • (7012) /
    • (9262) /

    Wo befindet sich MANTANA MARKETING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Apt 116 Heritage Court
    15 Warstone Lane
    B18 6NZ Hockley Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MANTANA MARKETING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ASHSTOCK 1769 LIMITED30. Juli 199930. Juli 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MANTANA MARKETING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2003

    Welche sind die letzten Einreichungen für MANTANA MARKETING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Beendigung der Bestellung von Nazar Hussain als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Karamjit Sagoo als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Karamjit Sagoo als Sekretär

    2 SeitenTM02

    legacy

    1 Seiten405(2)

    legacy

    1 Seiten405(2)

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    8 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return15. Sept. 2005

    legacy

    363(287)

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2003

    6 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    8 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return10. Feb. 2004

    legacy

    363(287)

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von MANTANA MARKETING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAG SECRETARIAL SERVICES (UK) LIMITED
    Hayer Building 190 Soho Hill
    Handsworth
    B19 1AG Birmingham
    Sekretär
    Hayer Building 190 Soho Hill
    Handsworth
    B19 1AG Birmingham
    49880440001
    SAGOO, Karamjit
    4 Mount Pleasant
    Kings Heath
    B14 7AL Birmingham
    Geschäftsführer
    4 Mount Pleasant
    Kings Heath
    B14 7AL Birmingham
    British82013740001
    HUSSAIN, Nazar
    384 Belchers Lane
    B9 5SU Bordesley Green
    West Midlands
    Sekretär
    384 Belchers Lane
    B9 5SU Bordesley Green
    West Midlands
    British115124620001
    SAGOO, Karamjit
    4 Mount Pleasant
    Kings Heath
    B14 7AL Birmingham
    Sekretär
    4 Mount Pleasant
    Kings Heath
    B14 7AL Birmingham
    British82013740001
    ASHBURTON REGISTRARS LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014760001
    ALI, Akbar
    58 Golden Hillock Road
    Small Heath
    B10 0LG Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    58 Golden Hillock Road
    Small Heath
    B10 0LG Birmingham
    West Midlands
    British65710110001
    KHAN, Raja
    11 Chesterton Road
    B12 8HL Birmingham
    Geschäftsführer
    11 Chesterton Road
    B12 8HL Birmingham
    British78642300002
    MIAN, Farhat Hameed
    124 Livery Street
    B3 1RS Birmingham
    Geschäftsführer
    124 Livery Street
    B3 1RS Birmingham
    British67641250002
    SAGOO, Karamjit
    4 Mount Pleasant
    Kings Heath
    B14 7AL Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    4 Mount Pleasant
    Kings Heath
    B14 7AL Birmingham
    West Midlands
    British64320710001
    SINGH, Amrik
    89 Court Road
    Balsall Heath
    B12 9LQ Birmingham
    Geschäftsführer
    89 Court Road
    Balsall Heath
    B12 9LQ Birmingham
    British62749690001
    SINGH, Gurdip Singh
    Apartment 116 Heritage Court
    15 Warstone Lane
    B18 6HU Hockley
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Apartment 116 Heritage Court
    15 Warstone Lane
    B18 6HU Hockley
    West Midlands
    British106650990001
    SINGH, Gurdip
    94 Middle Leaford
    Steechford
    B34 6HA Birmingham
    Geschäftsführer
    94 Middle Leaford
    Steechford
    B34 6HA Birmingham
    British60254320001
    AR NOMINEES LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014750001

    Hat MANTANA MARKETING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Commercial mortgage
    Erstellt am 10. Okt. 2002
    Geliefert am 22. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 70 marshall lane road shirley solihull west midlands insurance, goodwill, the benefit of all guarantees and warranties and by way of floating charge the. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Sun Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2006Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 3
    Commercial mortgage
    Erstellt am 10. Okt. 2002
    Geliefert am 22. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 39 rowan way chelmsley wood solihull west midlands insurance, goodwill, the benefit of all guarantees and warranties and by way of floating charge the. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Sun Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2006Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 2
    Commercial mortgage
    Erstellt am 10. Okt. 2002
    Geliefert am 22. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 69 braemar road sutton coldfield west midlands, insurance, goodwill, the benefit of all guarantees and warranties and by way of floating charge the. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Sun Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2006Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 120. Okt. 2020Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Commercial mortgage
    Erstellt am 26. Juli 2002
    Geliefert am 02. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    124 heritage court warstone lane birmingham west midlands. The proceeds of any insurance in respect of the property. The goodwill of the business carried on by the company at the property. The benefit of all guarantees warranties etc relating to the property. By way of floating charge all the undertaking and assets of the company not otherwise charged.
    Berechtigte Personen
    • Sun Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Commercial mortgage
    Erstellt am 26. Juli 2002
    Geliefert am 02. Aug. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    123 heritage court warstone lane birmingham west midlands. The proceeds of any insurance in respect of the property. The goodwill of the business carried on by the company at the property. The benefit of all guarantees warranties etc relating to the property. By way of floating charge all the undertaking and assets of the company not otherwise charged.
    Berechtigte Personen
    • Sun Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2006Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 426. Sept. 2020Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 4

    Hat MANTANA MARKETING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Okt. 2002Instrumentendatum
    Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Philip Midgley
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Praktiker
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Matthew William Hunt
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Praktiker
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    2
    DatumTyp
    10. Okt. 2002Instrumentendatum
    Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Philip Midgley
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Praktiker
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Matthew William Hunt
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Praktiker
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    3
    DatumTyp
    10. Okt. 2002Instrumentendatum
    Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Philip Midgley
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Praktiker
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Matthew William Hunt
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Praktiker
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    4
    DatumTyp
    26. Juli 2002Instrumentendatum
    Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew William Hunt
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Praktiker
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    John Philip Midgley
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath
    Praktiker
    Ccre Touchstone Ltd
    Colleagues House
    BA2 3AH 130-132 Wells Road
    Bath

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0