TELECITY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TELECITY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03819054 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TELECITY LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TELECITY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TELECITY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EVER 1190 LIMITED | 03. Aug. 1999 | 03. Aug. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TELECITY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TELECITY LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TELECITY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Jan. 2016 | 2 Seiten | 4.68 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Masters House 107 Hammersmith Road London W14 0QH zum 55 Baker Street London W1U 7EU am 12. Mai 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Ernennung von Wilhelmus Theresia Jozef Hageman als Direktor am 14. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von David Crowther als Direktor am 14. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Tobin als Geschäftsführer am 24. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Mcarthur-Muscroft als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Coupland am 29. Juni 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 25. Nov. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TELECITY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNTER, Anthony George | Sekretär | Baker Street W1U 7EU London 55 | British | 66859190003 | ||||||
| COUPLAND, Robert Andrew | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | 138313750002 | |||||
| CROWTHER, David | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | 184391050001 | |||||
| HAGEMAN, Wilhelmus Theresia Jozef | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | Netherlands | Dutch | 190923150001 | |||||
| COLEY, James Robert Ewen | Sekretär | Herongate 39 Meadow Drive SK10 4EY Prestbury Cheshire | British | 68949300004 | ||||||
| HAYMAN, Elizabeth Sara Jane | Sekretär | 54 Leyspring Road E11 3BX London | British | 40541160002 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | Sun Alliance House 35 Mosley Street NE1 1XX Newcastle Upon Tyne | 60471940003 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Sun Alliance House 35 Mosley Street NE1 1AN Newcastle Upon Tyne | 900018440001 | |||||||
| BARTON, Eric Anthony | Geschäftsführer | Glendale 9 Harebell Hill KT11 2RS Cobham Surrey | England | British | 1323220001 | |||||
| CORNISH, Alan Stewart | Geschäftsführer | Aspens 42 Oxenden Wood Road BR6 6HP Orpington Kent | British | 2757380001 | ||||||
| DUCKWORTH, Christopher John | Geschäftsführer | Hammond Field Hammond Drive Read BB12 7RE Burnley Lancashire | United Kingdom | British | 3889750006 | |||||
| ELLIS, Martyn Anthony | Geschäftsführer | 415 Caraway Apartments 2 Cayenne Court SE1 2PP Shad Thames London | British | 95749550001 | ||||||
| ELLMAUER, Josef | Geschäftsführer | Lessingstr 11 Bad Homburg Hessen 61350 Germany | Austrian | 76831300001 | ||||||
| FRY, Carl Duncan | Geschäftsführer | 19 Ennerdale Road TW9 3PG Richmond Surrey | United Kingdom | British | 71701130002 | |||||
| GINGELL, Matthew John | Geschäftsführer | Maple House 48a Braybrooke Road RG10 8DT Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 109220700001 | |||||
| HEPHER, Michael Leslie | Geschäftsführer | 2 Belgrave Mews North SW1X 8RS London | England | British | 54657730004 | |||||
| HUDSON, Ricky John | Geschäftsführer | 36 Ravenswood Avenue RG45 6AY Crowthorne Berkshire | British | 78305120002 | ||||||
| JOHNS, Leslie | Geschäftsführer | 55 Eynsford Rise Eynsford DA4 0HS Dartford Kent | British | 87198310001 | ||||||
| JOSHI, Manish Vinayakrai | Geschäftsführer | 56 Calbourne Road SW12 8LR London | British | 66301170001 | ||||||
| KAPOOR, Anish | Geschäftsführer | 1 Wingate Drive Didsbury M20 2RT Manchester Lancashire | England | British | 99037240001 | |||||
| KELLY, Michael Peter | Geschäftsführer | 40 Willow Park Fallowfield M14 6XT Manchester | British | 41598680001 | ||||||
| LEGENDRE, Alain | Geschäftsführer | Rue De Courcelles 119 FOREIGN Paris 75017 France | French | 77039550001 | ||||||
| MCARTHUR-MUSCROFT, Brian David | Geschäftsführer | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | England | British | 120812990001 | |||||
| TOBIN, Michael | Geschäftsführer | Masters House 107 Hammersmith Road W14 0QH London | England | British | 82337350003 | |||||
| TOOKEY, Glen Vincent | Geschäftsführer | 1 The Drive EN5 1DZ New Barnet Hertfordshire | British | 86639080002 | ||||||
| WADCOCK, Trevor Anthony | Geschäftsführer | 89 Victoria Road OX2 7QG Oxford | British | 79133200002 | ||||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Sun Alliance House 35 Mosley Street NE1 1AN Newcastle Upon Tyne | 900018430001 |
Hat TELECITY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Erstellt am 18. Sept. 2006 Geliefert am 30. Sept. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security accession deed | Erstellt am 19. Dez. 2005 Geliefert am 05. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage its interest in the material land, by way of fixed charge any right title or interest to or in any other land, the irish land which is not material irish land, all shares and all related distribution rights, all investments and all related distribution rights, all plant and machinery, all book debts and by way of floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juli 2003 Geliefert am 16. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TELECITY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0