TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03829147 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED?
- (5530) /
Wo befindet sich TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | BDO LLP 55 Baker Street W1U 7EU London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MISLEX (243) LIMITED | 20. Aug. 1999 | 20. Aug. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. März 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Adam Campbell als Geschäftsführer am 30. März 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||
Aufschub der Auflösung (freiwillig) | 1 Seiten | COLIQ | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Apr. 2013 | 11 Seiten | 4.68 | ||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 11 Seiten | 4.72 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Okt. 2012 | 11 Seiten | 4.68 | ||
Beendigung der Bestellung von David Page als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Okt. 2011 | 12 Seiten | 4.68 | ||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 3 Seiten | 2.34B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Apr. 2010 | 7 Seiten | 2.24B | ||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 3 Seiten | 2.23B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 14 Seiten | 2.16B | ||
Vorschlag des Verwalters | 76 Seiten | 2.17B | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Suite D 1 Lindsey Street London EC1A 9HP* am 25. Okt. 2009 | 1 Seiten | AD01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Michael Page am 05. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Paul Adam Campbell am 05. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Nicholas Chi Wai Wong am 05. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas Chi Wai Wong am 05. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||
Wer sind die Geschäftsführer von TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WONG, Nicholas Chi Wai | Sekretär | Suite D 1 Lindsey Street EC1A 9HP London | British | Company Director | 98701630002 | |||||
WONG, Nicholas Chi Wai | Geschäftsführer | Suite D 1 Lindsey Street EC1A 9HP London | United Kingdom | British | Company Director | 98701630002 | ||||
TAYLOR, Andrew Herbert Ian | Sekretär | 10 Aldwycks Close MK5 6HZ Milton Keynes | British | Accountant | 116794160001 | |||||
WOODCOCK, Timothy David | Sekretär | 71 Popes Avenue TW2 5TD Twickenham Middlesex | British | Director | 50887390003 | |||||
WESTLEX REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 21 Southampton Row WC1B 5HS London | 900005880001 | |||||||
BONNELL, William Andrew | Geschäftsführer | Walcroft Ashampstead Road RG8 8SU Basildon Berks | British | Managing Director | 101547740003 | |||||
BURNS, David | Geschäftsführer | 32 Festing Road SW15 1LP London | England | British | Banker | 67605640001 | ||||
CAMPBELL, Paul Adam | Geschäftsführer | Suite D 1 Lindsey Street EC1A 9HP London | United Kingdom | British | Company Director | 53606250003 | ||||
CURRY, Christopher John Max | Geschäftsführer | 41 Holland Street W8 4LX London | England | British | Director | 35538490003 | ||||
KITCHENER KEMP, Tracey | Geschäftsführer | Sutherland Grange Maindenhead Road S14 5TN Windsor The Lodge Berkshire United Kingdom | British | Managing Director | 118002660002 | |||||
MANKARIOUS, Nabil | Geschäftsführer | 42 Dunbar Avenue BR3 3RQ Beckenham Kent | United Kingdom | British | Company Director | 161494400001 | ||||
METCALF, John James | Geschäftsführer | Itchen Down House Itchen Down SO21 1BT Winchester Hampshire | British | Company Director | 35749990002 | |||||
PAGE, David Michael | Geschäftsführer | Suite D 1 Lindsey Street EC1A 9HP London | United Kingdom | British | Company Director | 3568360009 | ||||
SYKES, David John | Geschäftsführer | 93 Brambletye Park Road RH1 6EN Redhill Surrey | Uk | British | Company Director | 108164570001 | ||||
TAYLOR, Andrew Herbert Ian | Geschäftsführer | 10 Aldwycks Close MK5 6HZ Milton Keynes | United Kingdom | British | Accountant | 116794160001 | ||||
TWEDDELL, Crispin Noel Stephen | Geschäftsführer | 28 Leamington Road Villas W11 1HT London | England | British | Director | 3687790001 | ||||
WOODCOCK, Timothy David | Geschäftsführer | 71 Popes Avenue TW2 5TD Twickenham Middlesex | England | British | Director | 50887390003 | ||||
WESTLEX NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 21 Southampton Row WC1B 5HS London | 900005870001 |
Hat TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Erstellt am 23. Dez. 2008 Geliefert am 07. Jan. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £24,750 plus vat. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Aug. 2006 Geliefert am 11. Aug. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Juni 2005 Geliefert am 12. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of rental deposit | Erstellt am 28. Juli 2004 Geliefert am 17. Aug. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The interest-earning deposit account the initial deposit of £50,000.00 (the deposit account) and the amount at any time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deposit deed | Erstellt am 27. Jan. 2003 Geliefert am 06. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £2,500.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 18. Mai 2001 Geliefert am 19. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease dated 28TH june 1999 relating to the property known as ground floor and basement 1 battersea rise london SW11 | |
Kurze Angaben All interest in a bank deposit account in the name of paul harden & co or such other bank account to which the same may be transferred and the interest accrued thereon and all money withdrawn from the account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 02. Juni 2000 Geliefert am 15. Juni 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease and the rent deposit deed dated 2 june 2000 | |
Kurze Angaben £21,250 (the "deposit"). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment for keyman policies created by the company (formerly known as mislex (243) limited | Erstellt am 25. Feb. 2000 Geliefert am 02. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the following policies inclusive of all sums and bonuses accrued with royal & sun alliance 1). policy no. RNF00078490A life assured william andrew bonnell for the amount of £1,000,000 dated 14TH october 1999 for the term of 31 years 2).policy no. RNF00078491A life assured andrew herbert taylor for the amount of £250,000 dated 14TH october 1999 for the term of 33 years. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 08. Feb. 2000 Geliefert am 11. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the rent deposit deed | |
Kurze Angaben All money from titme to time withdrawn from the deposit account in accordance with the terms of the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 02. Feb. 2000 Geliefert am 03. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 22 august 1995 | |
Kurze Angaben £33,750. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 06. Dez. 1999 Geliefert am 08. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as mislex (243) limited to the chargee under the terms of the lease and/or the rent deposit deed | |
Kurze Angaben £33,600.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 06. Dez. 1999 Geliefert am 08. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (formerly known as mislex (243) limited to the chargee under the terms of the lease and/or the rent deposit deed | |
Kurze Angaben £32,700.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Nov. 1999 Geliefert am 25. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as mislex (243) limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a 147 church street london, 48 high street wimbledon village london, 120 holland park avenue london, (for full details of all properties charged see schedule to form 395) together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TOOTSIES RESTAURANTS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0