BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03833978 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bridge House Outwood Lane, LS18 4UP Horsforth, Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WORKALPHA LIMITED | 31. Aug. 1999 | 31. Aug. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Catherine Elizabeth Barton als Geschäftsführer am 05. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Juni 2018 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Notification of Bupa Care Homes (Cfg) Plc as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Ernennung von Catherine Elizabeth Barton als Direktor am 28. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Emmanuel Hynam als Geschäftsführer am 17. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms. Joan Martina Elliott als Direktor am 11. Aug. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. Juli 2016
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 038339780004 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Moore als Geschäftsführer am 29. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew John Cannon als Geschäftsführer am 23. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Emmanuel Hynam als Direktor am 23. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||
| ELLIOTT, Joan Martina | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 309829120001 | |||||
| PICKEN, Jonathan Stephen | Geschäftsführer | Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 189611450001 | |||||
| WALFORD, Arthur David | Sekretär | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | British | 6658190001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BARTON, Catherine Elizabeth | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 206964340001 | |||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||
| CANNON, Andrew John | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 200461360001 | |||||
| DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| DUGDALE, Michael Ian | Geschäftsführer | 29 Magnolia Dene HP15 7QE Hazlemere Buckinghamshire | British | 79570840001 | ||||||
| ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||
| GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | 107664270003 | |||||
| HOLDEN, Dean Allan | Geschäftsführer | Spring House Spring Hill Fordcombe TN3 0SE Tunbridge Wells Kent | British | 32671980002 | ||||||
| HYNAM, David Emmanuel | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 92485410001 | |||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||
| LOS, Steven Michael | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 116895800001 | |||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Geschäftsführer | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||
| MOORE, Keith | Geschäftsführer | Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 49217290002 | |||||
| REITER, Simon Philip | Geschäftsführer | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 England | United Kingdom | British | 135845570001 | |||||
| SMITH, Graham | Geschäftsführer | Moor Lane LS297AF Burley In Wharfedale Briarfield West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 142125320001 | |||||
| TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||
| TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||
| THOMAS, Oliver Henry Dixon | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 256549290001 | |||||
| WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 6658190001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bupa Care Homes (Cfg) Plc | 06. Apr. 2016 | Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds Bridge House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 19. Dez. 2013 Geliefert am 24. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture granting a first legal mortgage over all of the ordinary shares in bupa care homes (cfchomes) limited held by bupa care homes group limited and a floating charge over all of the assets and undertaking (present and future) of bupa care homes group limited. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Aug. 2012 Geliefert am 31. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the operating tenants and the company and the lessor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right title and other interests in the shares and floating charge undertaking and all its property rights and assets present and future see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. März 2012 Geliefert am 15. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the operating tenant, the operating tenant guarantor and the lessor to the issuer on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and other interest in the shares by way of floating charge the whole of the undertaking and all its property rights and assets whatsoever and wheresoever see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Feb. 2000 Geliefert am 03. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the chargee 1. the obligations as and when due; 2. to observe and perform in all respects the obligations on the part of the company contained in the debenture; and 3. all sums payable by the company under the debenture shall be paid without any deduction, set-off, counterclaim or withholding (unless required by law in which case the company will pay to the chargee an additional sum equivalent to the sum withheld and will provide evidence satisfactory to the chargee that the company has properly accounted to the relevant authority for the sum withheld or deducted) | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all right title estate and other interests of the chagor in the properties (other than the scottish properties). By way of floating charge the whole of the undertaking and all its property rights and assets whatsoever and wheresoever present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BUPA CARE HOMES GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0