BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03834928 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Huntingdon House 278-290 Huntingdon Street NG1 3LY Nottingham Nottinghamshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BOURNSTON (BRAMALL) LANE DEVELOPMENT LIMITED | 02. Sept. 1999 | 02. Sept. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip John Rothwell Barker als Direktor am 01. Okt. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tom Michael Kilmister als Geschäftsführer am 01. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Michael Kilmister als Geschäftsführer am 01. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2011 bis 30. Juni 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite G the Point Welbeck Road West Bridgford Nottingham Nottinghamshire NG2 7QW United Kingdom am 05. Sept. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ossington Chambers 6-8 Castle Gate Newark Nottinghamshire NG24 1AX am 22. Juni 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Huntingdon House 278-290 Huntingdon Street Nottingham Nottinghamshire NG1 3LY am 26. März 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Tom Michael Kilmister als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARKER, Philip John Rothwell | Geschäftsführer | 278-290 Huntingdon Street NG1 3LY Nottingham Huntingdon House Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | English | 71190750003 | |||||
| ALLWOOD, David | Sekretär | 3 Orchard Avenue NG13 8GD Bingham Nottinghamshire | British | 329505010001 | ||||||
| KILMISTER, Paul Michael | Sekretär | Low Farm Moor Lane Syerston NG23 5NA Newark Nottinghamshire | British | 10385760002 | ||||||
| SMITH-HILLIARD, Brandon Sandiford | Sekretär | The Lawn Back Lane Normanton On The Wolds NG12 5NP Keyworth Nottinghamshire | British | 97906820001 | ||||||
| ASHBURTON REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12-14 St Marys Street TF10 7AB Newport Shropshire | 900014760001 | |||||||
| KILMISTER, Paul Michael | Geschäftsführer | Low Farm Moor Lane Syerston NG23 5NA Newark Nottinghamshire | United Kingdom | British | 10385760002 | |||||
| KILMISTER, Tom Michael | Geschäftsführer | Moor Lane Syerston NG23 5NA Newark Low Farm Nottinghamshire England | England | British | 149368740001 | |||||
| WHYSALL, John Robin | Geschäftsführer | The Old School House Church Street NG12 1EN Shelford Nottinghamshire | England | British | 17977830001 | |||||
| AR NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12-14 St Marys Street TF10 7AB Newport Shropshire | 900014750001 |
Hat BOURNSTON (BRAMALL LANE DEVELOPMENT) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over letting and management agreement | Erstellt am 29. Juni 2001 Geliefert am 07. Juli 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter dated 24TH november 1999 (as amended by letter of variation dated 21ST may 2001) | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the letting and management agreement dated 27 july 2000 between bournston (bramall court) limited and sheffield hallam university enterprises limited ("shuel") together with a novation agreement dated 19TH march 2001 between shuel, bournston (bramall court) limited and bournston (bramall lane development) limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over construction contract | Erstellt am 02. Dez. 1999 Geliefert am 20. Dez. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document (as defined in the charge) under or pursuant to the terms of the facility agreement (as defined), the deed or any related security document or on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the contract and all related sums rights and benefit relating thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Dez. 1999 Geliefert am 20. Dez. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0