EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03839670
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Brunel Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4JW Corby
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROOMCO (1922) LIMITED10. Sept. 199910. Sept. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account cancelled 14/12/2011
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 1.00
    4 SeitenSH19

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011

    1 SeitenAA01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 25. Dez. 2009

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2007

    13 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    8 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2006

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WADE, Steve
    5 Horrocks Way
    NN15 5DH Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    5 Horrocks Way
    NN15 5DH Kettering
    Northamptonshire
    British117491680001
    LEWIS, Mitchell B
    Lazy Oaks Court
    GA30350 Atlanta
    8435
    Georgia
    United States Of America
    Geschäftsführer
    Lazy Oaks Court
    GA30350 Atlanta
    8435
    Georgia
    United States Of America
    UsaAmerican135352620001
    SMAILES, Nigel Andrew
    11 Nook Green
    Tingley
    WF3 1ER Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    11 Nook Green
    Tingley
    WF3 1ER Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish16154490003
    VANSANT, Robert Scott
    150 Brightmore Way
    Alpharetta
    FOREIGN Georgia
    30005
    Usa
    Geschäftsführer
    150 Brightmore Way
    Alpharetta
    FOREIGN Georgia
    30005
    Usa
    UsaAmerican92216760001
    PITTENDREIGH, Ian
    5 Stirling Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7LH Ilkley
    West Yorkshire
    Sekretär
    5 Stirling Road
    Burley In Wharfedale
    LS29 7LH Ilkley
    West Yorkshire
    British42432160002
    WILLIAMS, Paul Frederick
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    British18038590002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    COLLINS, Ronald Alvin
    21a Cheniston Gardens
    W8 6TG London
    Geschäftsführer
    21a Cheniston Gardens
    W8 6TG London
    British75185180001
    COMFORT, William Twyman
    11 Cadogan Street
    SW3 2PP London
    Geschäftsführer
    11 Cadogan Street
    SW3 2PP London
    American53760460002
    CUYPERS, Jo
    Heerbaan 57
    6061 Ec Posterholt
    31-475-401697
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    Heerbaan 57
    6061 Ec Posterholt
    31-475-401697
    The Netherlands
    Dutch77533550001
    PUGH, David Christopher
    16 Henley Close
    Rawdon
    LS19 6QB Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    16 Henley Close
    Rawdon
    LS19 6QB Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish50680510001
    SMITH, John David
    5130 Riverlake Drive
    Duluth
    Ga 30097
    Usa
    Geschäftsführer
    5130 Riverlake Drive
    Duluth
    Ga 30097
    Usa
    American92216850001
    WALTERS, Roger Anthony
    Woodstock Cottesmore Road
    Ashwell Oakham
    LE15 7LJ Rutland
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Woodstock Cottesmore Road
    Ashwell Oakham
    LE15 7LJ Rutland
    Leicestershire
    United KingdomBritish50421200001
    WILLIAMS, Paul Frederick
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    21 Alvington Way
    LE16 7NF Market Harborough
    Leicestershire
    British18038590002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Hat EURAMAX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Second lien charge over shares
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each credit party to the agents, the lenders or any of them and lender counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and all dividends interest or other monies paid or payable thereon or on respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag, London Branch as Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Secured Creditors (The Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second lien pledge agreement
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each credit party to the agents, the lenders or any of them and lender counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under the a) pledges equity interests and b) proceeds of or in respect of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Ag, New York Branch as Collateral Agent for the Secured Parties (The Collateral Agent)
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    First lien pledge agreement
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each credit party to the agents, the lenders or any of them and lender counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under the a) pledges equity interests and b) proceeds of or in respect of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation as Collateral Agent for the Secured Parties (Thecollateral Agent)
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    First lien debenture
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each credit party to the agents, the lenders or any of them and lender counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation as Agent and Trustee for Itself and Each of the Securedcreditors (The Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Third U.K. consent agreement
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 04. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The "secured obligations" meaning the guarantied obligations (as defined) of the company provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured obligations" to the extent that, if it were so included, the legal mortgage (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    The mortgaged shares. "Mortgaged shares" means such of the shares (as defined) as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to the transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage....please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas as Trustee for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third U.K. consent agreement
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 04. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The "secured obligations" meaning the guarantied obligations (as defined) of the company provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured obligations" to the extent that, if it were so included, the legal mortgage (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    The mortgaged shares. "Mortgaged shares" means such of the shares (as defined) as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to the transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage....please refer to form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bnp Paribas as Trustee for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Domestic consent agreement between the various parties (as named therein)
    Erstellt am 10. Apr. 2000
    Geliefert am 26. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The obligations and the guarantee obligations (both as defined) of the company and all obligations of the company under the agreement
    Kurze Angaben
    100 shares of $0.01 each in amerimax holdings inc. And all other shares rights dividends etc in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas (As Trustee for the Secured Creditors (as Defined))
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    U.K. consent agreement between the company, euramax international limited, euramax international inc., Euramax continental limited, euramax holdings limited, euramax european holdings limited, euramax europe limited, euramax coated products limited, ellbee limited and paribas
    Erstellt am 10. Apr. 2000
    Geliefert am 26. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The payment of all sums and the discharge of all liabilities constituting the secured obligations meaning the guarantied obligations (as defined) of the company provided that only 65 per cent of the mortgaged shares shall secure to the chargee the payment of all sums and the discharge of all liabilities constituting the us excluded liabilities (as defined)
    Kurze Angaben
    1. the mortgaged shares. "Mortgaged shares" means such of the shares (as defined) as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to the transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage.... "Shares" means any shares in the capital of the company referred to in the schedule to the form 395 and all dividends interest or other monies paid or payable thereon...". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas as Trustee for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Pledge agreement
    Erstellt am 22. Dez. 1999
    Geliefert am 24. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The obligations as defined the guarantied obligations (as defined) of the company and all obligations of the company under this agreement
    Kurze Angaben
    The company in the agreement pledged to the agent on behalf and for the ratable benefit of the secured parties and granted to the agent on behalf and for the ratable benefit of the secured parties.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas (As Trustee for the Secured Creditors (as Defined)
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage of shares
    Erstellt am 21. Dez. 1999
    Geliefert am 24. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The guarantied obligations (as defined) due or to become due from the company to the chargee under the terms of the legal mortgage of shares
    Kurze Angaben
    Such of the shares as are identified in the schedule to this form 395 and such other shares as the company may have transferred or be obliged to transfer to the mortgagee pursuant to clause 3.2 (subsequently acquired shares) of the legal mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas, as Trustee for the Secured Creditors (As Defined)
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 1999
    Geliefert am 24. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The guarantied obligations (as defined) of the company under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paribas (As Trustee for the Secured Creditors (as Defined)
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0