ELBON PFI FUND LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameELBON PFI FUND LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03846378
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ELBON PFI FUND LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich ELBON PFI FUND LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ELBON PFI FUND LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NOBLE PFI FUND LIMITED09. Nov. 199909. Nov. 1999
    DUNWILCO (733) LIMITED22. Sept. 199922. Sept. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ELBON PFI FUND LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ELBON PFI FUND LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für ELBON PFI FUND LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 30. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 3,734,250
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    49 SeitenAA

    Ernennung von Mr Jonathan Peter Doberman als Direktor am 04. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nestor Augusto Castillo Borrero als Geschäftsführer am 04. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 01. Juli 2015

    1 SeitenCH02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Dundas & Wilson Northwest Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ zum Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF am 01. Juli 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 20. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 3,734,250
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    11 SeitenAA

    Ernennung von Mr Nestor Augusto Castillo Borrero als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Michael Forrest als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Forrest am 21. Mai 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Forrest am 11. Nov. 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 23. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 3,734,250
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Forrest am 09. Okt. 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    53 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Infrastructure Managers Limited am 26. Feb. 2013

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 04. Sept. 2012

    2 SeitenCH02

    Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 04. Sept. 2012

    2 SeitenCH02

    Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 04. Sept. 2012

    2 SeitenCH02

    Änderung der Details des Sekretärs für Infrastructure Managers Limited am 25. Feb. 2013

    2 SeitenCH04

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 04. Sept. 2012

    2 SeitenCH02

    Wer sind die Geschäftsführer von ELBON PFI FUND LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Sekretär
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer05372427
    128530180002
    DOBERMAN, Jonathan Peter
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Palace Street
    SW1E 5JD London
    16
    United Kingdom
    United KingdomBritish201234400001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer06793845
    138240210001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Sekretär
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    613080003
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Sekretär
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    NOBLE PARTNERSHIP LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Sekretär
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    86014010001
    AUSTIN, Robert John
    The Cottage 8 Dockroyd
    Oakworth
    BD22 7RH Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Cottage 8 Dockroyd
    Oakworth
    BD22 7RH Keighley
    West Yorkshire
    British49285440001
    CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    EnglandBritish182601420001
    CHAPLIN, Robert Henry Moffett
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Lothian
    Geschäftsführer
    23 Moray Place
    EH3 6DA Edinburgh
    Lothian
    United KingdomBritish63131640001
    CHRISTIE, Rory
    56 South Trinity Road
    EH5 3NX Edinburgh
    Scotland
    Geschäftsführer
    56 South Trinity Road
    EH5 3NX Edinburgh
    Scotland
    United KingdomBritish59134900001
    CLARKE, Laurence Seymour
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    Geschäftsführer
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    EnglandBritish138241960001
    COPLEY, Peter Paul
    113 Shepherds Lane
    DA1 2PA Dartford
    Kent
    Geschäftsführer
    113 Shepherds Lane
    DA1 2PA Dartford
    Kent
    EnglandBritish66206120002
    CRAWFORD, Douglas James
    37 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Geschäftsführer
    37 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    British55793670001
    FORREST, Michael
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    Geschäftsführer
    c/o Dundas & Wilson
    Bush House
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing
    United KingdomBritish169634490002
    JESSOP, Alan Dixon
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    Geschäftsführer
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    British67849380002
    JESSOP, Alan Dixon
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    Geschäftsführer
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    British67849380002
    MCCULLOCH, Paul
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    Geschäftsführer
    33 Southwood Avenue
    Highgate
    N6 5SA London
    British101810930001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Geschäftsführer
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    British116580030002
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    Geschäftsführer
    The Cottage
    198 High Molewood
    SG14 2PJ Hertford
    United KingdomBritish85320540001
    PHILIPSZ, Joseph Eugene
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish,Irish83107910002
    POISON, Michael Buchanan
    11 Craighall Gardens
    EH6 4RH Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    11 Craighall Gardens
    EH6 4RH Edinburgh
    Midlothian
    British66143250001
    RAY, Alistair Graham
    305 Rotherhithe Street
    SE16 5EQ London
    Geschäftsführer
    305 Rotherhithe Street
    SE16 5EQ London
    British77528420002
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Geschäftsführer
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Geschäftsführer
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    Geschäftsführer
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    British59658050001
    THOMSON, Benjamin John Paget
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    British44243290003

    Hat ELBON PFI FUND LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 2011
    Geliefert am 10. Aug. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of confirmation to security agreement
    Erstellt am 19. Dez. 2007
    Geliefert am 28. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee and the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and related rights, the assigned document. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for Each of the Other Financeparties
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation to security agreement
    Erstellt am 19. Dez. 2007
    Geliefert am 28. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrower to the chargee and the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and related rights, the assigned document. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for Each of the Other Financeparties
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation to debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2007
    Geliefert am 28. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation to debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2007
    Geliefert am 28. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 09. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First legal mortgage all of the shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 09. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First legal mortgage all of the shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 09. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 09. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 05. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrowers to the chargee and the senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares in dumfries facilities holdings limited, and the related rights meaning all rights to dividends and other distributions paid or payable and all stocks, shares or other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for Each of the Other Financeparties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 05. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrowers to the chargee and the senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The shares in alpha schools (west lothian) holdings limited, and the related rights meaning all rights to dividends and other distributions paid or payable and all stocks, shares or other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for Each of the Other Financeparties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 05. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the shares in gh ppp holdings limited, noble pfi fund (investments) limited and the dividends paid or payable and all stocks, shares, securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of confirmation
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 05. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Shares means all shares in blackshaw healthcare services holdings limited, gh bury holdings limited, gh newham holdings limited, for details of further shares charged please refer to form 395, all dividends paid or payable, all stocks, shares, securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for Each of the Other Financeparties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Sept. 2004
    Geliefert am 07. Okt. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the senior creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage its present and future interest in the 2004 holdco cbis and all payments in respect thereof and all other rights in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 30. Jan. 2002
    Geliefert am 05. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and the senior creditors. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all of the shares, all dividends, all the new anavon loan notes.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Aug. 2001
    Geliefert am 18. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee and the senior creditors (or any of them), under the debenture and under the senior facility agreement and any finance document to which it is a party and/or any deed or document supplemental thereto on any account whatsoever. (All terms as defined)
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all of the shares all of the dividends paid or payable. By way of assignment all the rights, titles, benefits and interests of the chargor whatsoever after the date of the debenture.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC Acting for Itself and as Agent and Security Trustee Forand on Behalf of the Senior Creditors
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Security agreement
    Erstellt am 03. Aug. 2001
    Geliefert am 18. Aug. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee and the senior creditors (or any of them) under the security agreement and under the senior facility agreement and each other finance document and the borrower under the senior facility agreement and each other finance document to which it is a party and/or in any case any deed or document supplemental thereto on any account whatsoever. (All terms as defined)
    Kurze Angaben
    The shares and the related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC Acting for Itself and as Agent and Security Trusteefor and on Behalf of the Senior Creditors
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Pledge agreement
    Erstellt am 01. Juni 2001
    Geliefert am 15. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All sums due and to become due from inverness air terminal limited to the chargee whether as principal debtor, co-obligant, guarantor or otherwise in any manner of way (including all present, future or contingent obligations owed whether such obligations exist now or arise in future) together with interest, costs, fees, commissions, expenses and charges
    Kurze Angaben
    The pledged securities meaning the entire issued share capital of the company and the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 01. Juni 2001
    Geliefert am 12. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities of (a) the chargor to the security trustee and the senior creditors (as defined), or any of them, and under the senior facility agreement (as defined) and any finance document (as defined) to which it is a party and/or (b) any deed or document supplemental thereto
    Kurze Angaben
    All shares,as defined,and related rights and all guarantees,indemnities,debentures and other security. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC, London, as Agent and Security Trustee for and Onbehalf of the Senior Creditors
    Transaktionen
    • 12. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juni 2001
    Geliefert am 12. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities of (a) the chargor to the security trustee and the senior creditors (as defined), or any of them, and under the senior facility agreement (as defined) and any finance document (as defined) to which it is a party and/or (b) any deed or document supplemental thereto
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC, London, as Agent and Security Trustee for and Onbehalf of the Senior Creditors
    Transaktionen
    • 12. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Account charge between the company,barr castlehill holdings limited and national westminster bank PLC (as "security trustee" and "security bank")
    Erstellt am 01. Juni 2001
    Geliefert am 09. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    The obligation of the company (the "fund") to subscribe the 14% parent cbis (as defined) in barr castlehill holdings limited ("holdco") under the 14% parent cbis instrument (as defined)
    Kurze Angaben
    First fixed charge over the cash collateral (as defined),the fund cash collateral account (as defined) and the debt represented thereby and all interest thereon with all related rights,benefit and interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barr Castlehill Holdings Limited
    Transaktionen
    • 09. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0