EUROBET UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEUROBET UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03849156
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EUROBET UK LIMITED?

    • Glücksspiel- und Wettbetriebe (92000) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich EUROBET UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite A 7th Floor
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EUROBET UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CORAL INTERNET LIMITED07. Dez. 199907. Dez. 1999
    CORAL INTERNATIONAL LIMITED14. Okt. 199914. Okt. 1999
    ALNERY NO. 1900 LIMITED28. Sept. 199928. Sept. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROBET UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis26. Sept. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für EUROBET UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    21 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT zum Suite a 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS am 22. Dez. 2017

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Nov. 2017

    LRESSP

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 038491560010 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. März 2017

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Carl Anthony Leaver als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 31. Okt. 2016

    • Kapital: GBP 4.000001
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Ernennung von Harry Willits als Direktor am 13. Sept. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Gala Coral Nominees Limited als Geschäftsführer am 13. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Sept. 2015

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 16. Juni 2016

    • Kapital: GBP 4,000,001
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Gala Coral Nominees Limited am 15. Feb. 2013

    1 SeitenCH02

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 7

    5 SeitenMR05

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2014

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 15. Mai 2015

    • Kapital: GBP 4,000,001
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Sept. 2013

    19 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von EUROBET UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILLITS, Harry
    7th Floor
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A
    Nottingham
    Sekretär
    7th Floor
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A
    Nottingham
    160642800001
    BOWTELL, Paul
    7th Floor
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A
    Nottingham
    Geschäftsführer
    7th Floor
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A
    Nottingham
    United KingdomBritish164343080001
    TEMPLEMAN, Robert William
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish159382420002
    WILLITS, Harry Andrew
    7th Floor
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A
    Nottingham
    Geschäftsführer
    7th Floor
    City Gate East
    NG1 5FS Tollhouse Hill
    Suite A
    Nottingham
    United KingdomBritish175965490001
    PENFOLD, Diane June
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Sekretär
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    148030460001
    WHITEHEAD, Philip Ernest
    3 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    3 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    British48512990001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Sekretär
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    BEAUMONT, Trevor Kenneth
    9 Pyne Gale
    Galleywood
    CM2 8QG Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    9 Pyne Gale
    Galleywood
    CM2 8QG Chelmsford
    Essex
    EnglandBritish109954570001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    EnglandBritish151637880001
    HARRISON, Dominic Stephen
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    United KingdomBritish107909600001
    HUGHES, Gary William
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    ScotlandBritish151269910001
    LEAVER, Carl Anthony
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish159381090001
    MARISCOTTI, Michael Gordon
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Redcraft
    Spencers Green
    HP23 6LA Tring
    Hertfordshire
    British17449850001
    RICHARDSON, Lee Wayne
    32 The Birches
    Cove
    GU14 9RP Farnborough
    Hampshire
    Geschäftsführer
    32 The Birches
    Cove
    GU14 9RP Farnborough
    Hampshire
    EnglandBritish116082950001
    WHITEHEAD, Philip Ernest
    3 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    3 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish48512990001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02968120
    76454320002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EUROBET UK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    England
    25. Aug. 2016
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited By Share
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer10347154
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat EUROBET UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 07. Apr. 2014
    Geliefert am 25. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    • Goldman Sachs International (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (And Its Successors in Title and Permitted Transferees)
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 23. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    • Mehr als vier berechtigte Personen Ja
    Deed of pledge over share quota
    Erstellt am 11. Juli 2011
    Geliefert am 08. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledged assets defined as, together the quota and the related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Acting as Security Agent)
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 22. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 27. Mai 2011
    Geliefert am 10. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Acting as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 27. Mai 2011
    Geliefert am 10. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest in or to the collateral see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Acting as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Sept. 2015Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 22. Nov. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 23. Dez. 2005
    Geliefert am 03. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property being stadium and cromer road and spring garden car parks essex t/n EGL386379. F/h property being lessington avenue/ esher avenue car park essex t/n EGL293249. F/h property being employee house number 1 lessington avenue essex t/n EGL72046. For further details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security accession deed
    Erstellt am 10. Dez. 2004
    Geliefert am 21. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (Security Agent)
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Feb. 2004
    Geliefert am 20. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 17. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent for Itself and the Other Secured Parties)(the Security Agent)
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Feb. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession
    Erstellt am 16. Mai 2000
    Geliefert am 01. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company and each of the other obligors (as defined) to the chargee (the "security agent") or the other secured parties (as defined) under the senior finance documents (as defined) or any of them and under the debenture and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EUROBET UK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Dez. 2018Aufgelöst am
    27. Nov. 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Adrian David Allen
    Suite A, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praktiker
    Suite A, 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0