PASTICHE BISTRO LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePASTICHE BISTRO LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03852203
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PASTICHE BISTRO LTD?

    • (5530) /

    Wo befindet sich PASTICHE BISTRO LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    St Matthews House
    Haugh Lane Industrial Estate
    NE46 3PU Hexham
    Northumberland
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PASTICHE BISTRO LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für PASTICHE BISTRO LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Okt. 2009

    15 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 28. Okt. 2009

    15 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 28. Apr. 2009

    10 Seiten2.24B

    Vorschlag des Verwalters

    19 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2007

    9 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    14 Seiten395

    legacy

    9 Seiten155(6)a

    legacy

    9 Seiten155(6)b

    legacy

    9 Seiten155(6)b

    legacy

    9 Seiten155(6)a

    legacy

    9 Seiten155(6)b

    legacy

    9 Seiten155(6)b

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07

    Beschlüsse

    Resolutions
    9 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von PASTICHE BISTRO LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CHAPMAN, Elaine
    Bewsehill Crescent
    NE21 6BW Winlaton
    39
    Tyne And Wear
    Sekretär
    Bewsehill Crescent
    NE21 6BW Winlaton
    39
    Tyne And Wear
    British128633130001
    LILLEY, Paul Neil
    Lee Moor House
    Juniper
    NE46 1SS Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Lee Moor House
    Juniper
    NE46 1SS Hexham
    Northumberland
    United KingdomBritish83531040003
    SULLIVAN, Christopher John
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish101400140001
    BARKER, Peter
    Robindale Blythe Bridge Bank
    Kingstone
    ST14 8QW Uttoxeter
    Staffordshire
    Sekretär
    Robindale Blythe Bridge Bank
    Kingstone
    ST14 8QW Uttoxeter
    Staffordshire
    British101335070001
    BOSS, Helen
    The Spinney
    21 West Butts Road
    WS15 2LS Rugeley
    Staffordshire
    Sekretär
    The Spinney
    21 West Butts Road
    WS15 2LS Rugeley
    Staffordshire
    British66522660004
    EDWARDS, Paul Alexander
    Lauriston
    62 Main Road
    NE40 3AJ Ryton
    Tyne & Wear
    Sekretär
    Lauriston
    62 Main Road
    NE40 3AJ Ryton
    Tyne & Wear
    British91098740003
    LILLEY, Francesca Ariadne Harvey
    Lee Moor House
    Juniper
    NE46 1SS Hexham
    Northumberland
    Sekretär
    Lee Moor House
    Juniper
    NE46 1SS Hexham
    Northumberland
    British88765130003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ASHMORE, John Philip
    College Farm
    WS15 3DH Abbots Bromley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    College Farm
    WS15 3DH Abbots Bromley
    Staffordshire
    EnglandBritish112118630001
    WOODS, Brian Reginald
    8 Rising Brook
    ST17 9DA Stafford
    Geschäftsführer
    8 Rising Brook
    ST17 9DA Stafford
    British68411100002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat PASTICHE BISTRO LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2007
    Geliefert am 25. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries or any of them or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Paul Neil Lilley for Each of the Security Beneficiaries
    Transaktionen
    • 25. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2007
    Geliefert am 18. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alliance & Leicester Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Sept. 2007
    Geliefert am 13. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Octopus Investments Limited (As Security Trustee for the Security Beneficiaries) (the Trust)
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the shire group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 1-2 mill street stafford staffordshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the shire group limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 7 lendal york north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 09. Nov. 2005
    Geliefert am 23. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Dez. 1999
    Geliefert am 07. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PASTICHE BISTRO LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Okt. 2008Beginn der Verwaltung
    28. Okt. 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew D Haslam
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Simon Lundy
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    2 Collingwood Street
    NE1 1JF Newcastle Upon Tyne

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0