PADRINO PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PADRINO PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03854092 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PADRINO PROPERTIES LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich PADRINO PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 81 Station Road SL7 1NS Marlow Bucks |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PADRINO PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PADRINO PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 16 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 23. Nov. 2018 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 105 Wigmore Street London W1U 1QY zum 81 Station Road Marlow Bucks SL7 1NS am 13. Dez. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||||||||||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2016 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2014 bis 30. Apr. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 19. Dez. 2014 | 2 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr George Raymond Iestyn Llewellyn Smith am 01. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William James Killick am 01. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 20 Balderton Street London W1K 6TL zum 105 Wigmore Street London W1U 1QY am 02. Sept. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PADRINO PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILLICK, William James | Geschäftsführer | Station Road SL7 1NS Marlow 81 Bucks | England | British | 71352980002 | |||||
| LLEWELLYN SMITH, George Raymond Iestyn | Geschäftsführer | Station Road SL7 1NS Marlow 81 Bucks | United Kingdom | British | 161701390001 | |||||
| GOLDSMITH, Christopher William | Sekretär | Warehouse 33 Bridge Street CB2 1UW Cambridge The United Kingdom | British | 13230340005 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BARNES, Sara Anne | Geschäftsführer | Warehouse 33 Bridge Street CB2 1UW Cambridge The United Kingdom | United Kingdom | British | 98921440001 | |||||
| CARTER, Andrew Stewart | Geschäftsführer | 55 Gracechurch Street EC3V 0UF London | United Kingdom | British | 145669000001 | |||||
| CARTER, Andrew Stewart | Geschäftsführer | 55 Gracechurch Street EC3V 0UF London | United Kingdom | British | 145669000001 | |||||
| GOLDSMITH, Christopher William | Geschäftsführer | Balderton Street W1K 6TL London 20 England | England | British | 13230340006 | |||||
| HUGHSON, David Callum | Geschäftsführer | 55 Gracechurch Street EC3V 0UF London | British | 62284790002 | ||||||
| MARTIN, Julia Helen | Geschäftsführer | 79 Streathbourne Road SW17 8RA London | British | 84688790001 | ||||||
| MARTIN, Julia Helen | Geschäftsführer | 79 Streathbourne Road SW17 8RA London | British | 84688790001 | ||||||
| MAXEY, Christopher John | Geschäftsführer | Elmsted Skreens Park Road Roxwell CM1 4NL Chelmsford Essex | United Kingdom | British | 46329910002 | |||||
| MOULDER, Stuart Christopher | Geschäftsführer | Uvongo House Blackmore Road Blackmore CM4 0QX Ingatestone Essex | England | British | 46329920001 | |||||
| PARDOE, Richard Grenville | Geschäftsführer | Cherry Tree Cottage 17 West Avenue HP10 8AE Penn Buckinghamshire | England | British | 141544990001 | |||||
| PETTIT, Andrew John | Geschäftsführer | Balderton Street W1K 6TL London 20 | England | British | 62947400004 | |||||
| SCOTT, Nicholas Peter | Geschäftsführer | 7 Poplar Close Great Gransden SG19 3AX Sandy Bedfordshire | England | British | 108455130001 | |||||
| TAME, Russell | Geschäftsführer | Orchard House 1a Mill Road CB21 5LT West Wratting Cambridgeshire | British | 117422530001 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PADRINO PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westgate Quarter Llp | 18. Apr. 2016 | Wigmore Street W1U 1QY London 105 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat PADRINO PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 31. Juli 2012 Geliefert am 06. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that f/h land k/a 63-69 (odd) westgate streeet ipswich t/no.SK49426. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Juli 2012 Geliefert am 03. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a civic centre westgate street ipswich t/no SK297768 and f/h property k/a 63-69 (odd) westgate street ipswich t/no SK49426 by way of first fixed charge all it rights in each insurance policy the benefit of all other contracts guarantees appointments and warranties see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 31. Juli 2012 Geliefert am 03. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrower and the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a civic centre westgate street ipswich t/no by way of fixed charge all its rights in each insurance policy the benefit of all other contracts guarantees appointments and warranties SK297768 f/h property k/a 63-69 (odd) westgate street ipswich t/no SK49426 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Juli 2007 Geliefert am 07. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 02. Apr. 2001 Geliefert am 18. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H proeprty k/a 136-138 lower mortlake road richmond - SY103299 SGL417634 and SGL201977 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 06. Nov. 2000 Geliefert am 10. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Clarendon house london road chelmsford t/n EX411282 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 22. Sept. 2000 Geliefert am 05. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a part ground floor and mezzanine floor the quays concordia street leeds west yorkshire. Assigns the goodwill of the business the benefit of the licences and by way of floating charge the undertaking and all other property and assets both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge deed | Erstellt am 17. Dez. 1999 Geliefert am 07. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Ambassador house brigstok road bensham moor road thornton heath croydon also ground floor parking spaces 194 to 216 chancellor court bensham moor road together. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. Assigns the goodwill of the business the benefit of the licences and by way of floating charge the undertaking and all other property and assets both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat PADRINO PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Receiver/Manager bestellt |
| |||||||||||||||||||||||
| 2 | Receiver/Manager bestellt |
| |||||||||||||||||||||||
| 3 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0