PERFECTTASTE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PERFECTTASTE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03855837 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PERFECTTASTE LIMITED?
- Rundfunk (60100) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich PERFECTTASTE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 London Bridge Street SE1 9GF London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Gesch äftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PERFECTTASTE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Juni 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PERFECTTASTE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Juni 2020 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 6 Seiten | AA | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Juli 2018 | 5 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Scott William Taunton am 02. März 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 4 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony David Tompkins als Geschäftsführer am 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Norman Mckeown als Geschäftsführer am 30. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2016 bis 30. Juni 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||
Ernennung von Mr Michael Charles Gill als Direktor am 30. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Anthony Tompkins als Sekretär am 30. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr Christopher Charles Stoddart Longcroft als Direktor am 30. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Scott William Taunton am 19. Dez. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor 401 Faraday Street, Birchwood Park Warrington WA3 6GA England zum 1 London Bridge Street London SE1 9GF am 02. Dez. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von John Mccann als Geschäftsführer am 12. Mai 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von PERFECTTASTE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILL, Michael Charles | Geschäftsführer | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | United Kingdom | British | Accountant | 123013340001 | ||||
LONGCROFT, Christopher Charles Stoddart | Geschäftsführer | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | England | British | Chief Financial Officer | 163116880001 | ||||
TAUNTON, Scott William | Geschäftsführer | London Bridge Street SE1 9GF London 1 United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 80505610007 | ||||
DOWNEY, James Robinson | Sekretär | 33 Karrington Heights Comber Road Dundonald BT16 1XZ Belfast County Antrim Northern Ireland | British | 107097580001 | ||||||
HUGHES, Paul | Sekretär | 35 Tavistock Close TS27 3LB Hartlepool Cleveland | British | 66641750002 | ||||||
JOSEPHS, John Irving | Sekretär | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 3830990001 | ||||||
ROBINSON, Adrian Mervyn | Sekretär | 6 Glenard Hall Goatstown Road IRISH Clonskeagh Dublin 14 Ireland | Irish | Accountant | 77585790001 | |||||
TOMPKINS, Anthony | Sekretär | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | 165685240001 | |||||||
JL NOMINEES TWO LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
APPEL, Beate | Geschäftsführer | Naugarder Str 43 FOREIGN Berlin D-10409 Germany | German | Manager | 80505900001 | |||||
DOBSON, Maurice John | Geschäftsführer | 14 Haughton Terrace NE24 2HA Blyth Northumberland | United Kingdom | British | Director | 47946730001 | ||||
DOBSON, Michael John | Geschäftsführer | 7 Beech View Sowerby Bridge HX6 2JQ Halifax | British | Director | 74423050002 | |||||
DUNNE, George Henry | Geschäftsführer | 27 The Bridle Woodham Village DL5 4TH Newton Aycliffe County Durham | British | Director | 72942820001 | |||||
ENGLAND, Philip Charles | Geschäftsführer | Lime House Kershaw Grove SK11 8TN Macclesfield Cheshire | British | Director | 46909530002 | |||||
JOSEPHS, John Irving | Geschäftsführer | 22 Osbaldeston Gardens NE3 4JE Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | Director | 3830990001 | ||||
LAWRENCE, Eric Alexander | Geschäftsführer | 26 Foxhills Covert Whickham NE16 5TN Newcastle Upon Tyne | British | Managing Director | 4250810002 | |||||
MCCANN, John | Geschäftsführer | 175 Malone Road BT9 6TB Belfast County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | British | Managing Director | 75447990001 | ||||
MCKEOWN, Norman | Geschäftsführer | Ormeau Road BT7 1EB Belfast Havelock House Northern Ireland | Northern Ireland | British | Director | 165664890001 | ||||
O'DRISCOLL, Donnach Joseph | Geschäftsführer | Apartment D1 Montevetro Building 100 Battersea Church Road SW11 3YL London | United Kingdom | Irish | Business Man | 77585670001 | ||||
POELMANN, Rainer | Geschäftsführer | Igelpfad 21a Kleinmachnow D 14532 Germany | German | Company Director | 80601390001 | |||||
ROBINSON, Adrian Mervyn | Geschäftsführer | 6 Glenard Hall Goatstown Road IRISH Clonskeagh Dublin 14 Ireland | Ireland | Irish | Accountant | 77585790001 | ||||
SQUIRE, Giles | Geschäftsführer | The Old Vicarage The Village NE65 9BL Morpeth Northumberland | England | British | Director | 109514810001 | ||||
THORNTON, Paul | Geschäftsführer | 41 Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford West Yorkshire | British | Sales Director | 70512630001 | |||||
TOMPKINS, Anthony David | Geschäftsführer | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | England | British | Finance Director | 165684030001 | ||||
JL NOMINEES ONE LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PERFECTTASTE LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wireless Group Media (Gb) Limited | 06. Apr. 2016 | London Bridge Street SE1 9GF London 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat PERFECTTASTE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 26. Sept. 2003 Geliefert am 14. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 26. Sept. 2003 Geliefert am 03. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The charged account being barclays bank re PLC perfecttaste limited current account, account number 00814091. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Okt. 2002 Geliefert am 22. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Sept. 2002 Geliefert am 02. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures and fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Dez. 2001 Geliefert am 14. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0