SANCTUARY CARE (UK) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SANCTUARY CARE (UK) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03856062 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SANCTUARY CARE (UK) LIMITED?
- Betreuungseinrichtungen für ältere und behinderte Menschen (87300) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich SANCTUARY CARE (UK) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Sanctuary House, Chamber Court Castle Street WR1 3ZQ Worcester England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SANCTUARY CARE (UK) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
EMBRACE (UK) LIMITED | 30. Juni 2014 | 30. Juni 2014 |
EUROPEAN CARE (UK) LIMITED | 20. Juni 2000 | 20. Juni 2000 |
EUROPEAN CARE 2000 LTD | 17. Nov. 1999 | 17. Nov. 1999 |
TIMEFOOT LTD | 08. Okt. 1999 | 08. Okt. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SANCTUARY CARE (UK) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SANCTUARY CARE (UK) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 31 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Okt. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Juli 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 31 Seiten | MA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 08. Juli 2020
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2019 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Neil King als Geschäftsführer am 25. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Edward Henry Lunt als Direktor am 22. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter John Williams als Direktor am 01. Jan. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Jon Moule als Geschäftsführer am 01. Jan. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Zweite Einreichung für die Abberufung von Craig Moule als Sekretär | 5 Seiten | RP04TM02 | ||||||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Nicole Seymour zum Sekretär | 6 Seiten | RP04AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Jon Moule als Sekretär am 25. Mai 2018 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SANCTUARY CARE (UK) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEYMOUR, Nicole | Sekretär | Chamber Court Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House England | 246820780001 | |||||||
LUNT, Edward Henry | Geschäftsführer | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | England | British | Director | 258777900001 | ||||
WARREN, Nathan Lee | Geschäftsführer | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | United Kingdom | British | Director | 130959110002 | ||||
WHITMORE, James Robert | Geschäftsführer | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | England | British | Director | 209804070001 | ||||
WILLIAMS, Peter John | Geschäftsführer | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | England | British | Director | 163514920001 | ||||
AMLANI, Pritesh | Sekretär | Birling Road Ryarsh ME19 5LS West Malling Ryarsh Oast House Kent United Kingdom | British | 125206220002 | ||||||
ANOUP, Treon | Sekretär | Apt 1 7 Cambridge Gate Regents Park NW1 4JX London | British | Director | 110454990001 | |||||
ATKINSON, Sophie | Sekretär | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | 234231700001 | |||||||
KANDELAKI, Katharine Amelia Christabel | Sekretär | Two Parklands Building Parklands Rubery B45 9PZ Birmingham Part Ground Floor & First Floor United Kingdom | 160345160001 | |||||||
MITCHELL, Stephen Murray | Sekretär | 9 Norland Square W11 4PX London | British | Solicitor | 4094400001 | |||||
MOULE, Craig Jon | Sekretär | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | 240622940001 | |||||||
FORM 10 SECRETARIES FD LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900014000001 | |||||||
INTERNATIONAL CORPORATE FINANCE LTD | Sekretär | 13 Hazel Mead Arkley EN5 3LP Barnet Hertfordshire | 56231470001 | |||||||
AMLANI, Pritesh | Geschäftsführer | Welbeck Street W1G 8EW London 28 | England | British | None | 125206220002 | ||||
ANOUP, Treon | Geschäftsführer | Apt 1 7 Cambridge Gate Regents Park NW1 4JX London | United Kingdom | British | Director | 110454990001 | ||||
FARRALL, Elaine Ann | Geschäftsführer | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | Director | 14241020001 | |||||
KING, Anthony Neil | Geschäftsführer | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | England | British | Director | 9255540009 | ||||
LEE, Patricia Lesley | Geschäftsführer | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | United Kingdom | British | Chief Executive | 192233540001 | ||||
MANSON, David Lindsay | Geschäftsführer | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | United Kingdom | British | Director | 167628190001 | ||||
MITCHELL, Stephen Murray | Geschäftsführer | 9 Norland Square W11 4PX London | United Kingdom | British | Director | 4094400001 | ||||
MOULE, Craig Jon | Geschäftsführer | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House, Chamber Court England | England | British | Director | 135984850005 | ||||
PERRY, David William | Geschäftsführer | Welbeck Street W1G 8EW London 28 | England | British | None | 33988060002 | ||||
SMITH, Albert Edward | Geschäftsführer | Two Parklands Building Parklands Rubery B45 9PZ Birmingham Part Ground Floor & First Floor United Kingdom | England | British | Director | 77631340001 | ||||
TREON, Jaynee Sunita | Geschäftsführer | 28 Welbeck Street London W1G 8EW | United Kingdom | British | Director | 42532090004 | ||||
FORM 10 DIRECTORS FD LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 39a Leicester Road Salford M7 4AS Manchester Lancashire | 900013990001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SANCTUARY CARE (UK) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanctuary Care (North) Limited | 06. Apr. 2016 | Castle Street WR1 3ZQ Worcester Sanctuary House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SANCTUARY CARE (UK) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 08. Jan. 2016 Geliefert am 12. Jan. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Sydmar lodge - sydmar lodge, 201 hale lane, edgware, HA8 9QH (title number AGL343829). Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 31. März 2015 Geliefert am 04. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung L/H dovecote dovecote nursing home hugar road high spen rowlands gill t/no TY383192 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 31. März 2015 Geliefert am 04. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Juli 2012 Geliefert am 03. Aug. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H properties k/a 27 highfield road street somerset t/no WS14333 & WS40928, topping fold road bury lancashire t/no GM886779, hugar road high spen rowlands gill t/no TY383192 for details of further property charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 04. März 2010 Geliefert am 06. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a bridge house topping fold road bury greater manchester BL9 7NQ t/n GM88779 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a st cuthberts residential care home riga square hylton red house sunderland tyne and wear SR5 5DD t/n TY383203 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a dovecote nursing home hugar road high spen gateshead tyne and wear NE39 2BQ t/n TY383192 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a hawkesgarth lodge nursing home station road hawker whitby north yorkshire YO22 4LB t/n NYK255727 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h properties k/a arthurs court nursing home 27 higfield road street somerset BA16 0JJ t/n WS14333 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h properties k/a high peak lodge nursing home bedford square chapel street leigh manchester WN7 2AA t/n GM897514 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a rosewell country home church hill high littleton somerset BS39 6HF t/n ST201392 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a peel gardens nursing home vivary way colne lancashire BB8 9PR and t/n LA904026 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a lakeview nursing home chorley road withnell lancashire PR6 8BG and t/n LA902715 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a high peak nursing home main lane kenyon warrington cheshire WA3 4AZ t/n CH485993 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 2003 Geliefert am 31. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a guy's court nursing home 409/411 poulton road fleetwood lancashire FY7 7JY t/n LA896864 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Dez. 2001 Geliefert am 18. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Leasehold property k/a st. Cuthberts residential care home rigar square hylton red house sunderland tyne and wear t/n TY273098. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Dez. 2001 Geliefert am 18. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a dovecote nursing home hugar road high spen tyne and wear NE39 2BQ t/n TY281469 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The leasehold property known as lakeview nursing home chorley road withnell chorley lancashire title number LA619562 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 14. Nov. 2001 Geliefert am 04. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The l/h property k/a arthur's court nursing home, highfield road, street, BA16 ojj t/ns ST126951, ST117727 and ST109206 and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 14. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The leasehold property known as rosewell country home church hill high littleton bath title number ST137967 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 25. Juli 2001 Geliefert am 27. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Juli 2001 Geliefert am 27. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H property k/a guy's court nursing home 409/411 poulton road fleetwood lancashire t/no's;-LA678914 and LA803724. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Juli 2001 Geliefert am 27. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben L/H property k/a high peak nursing home main lane kenyon warrington t/no;-CH375761. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0