ASPECTIVE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASPECTIVE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03866545 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASPECTIVE LIMITED?
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ASPECTIVE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASPECTIVE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASPECTIVE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Apr. 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 8 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Mrs Janine Butler als Direktor am 23. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Nigel Evans als Geschäftsführer am 23. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 10 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 256 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Michael Yorston als Direktor am 02. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Diane Josephine Mcintyre als Geschäftsführer am 16. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Vodafone House the Connection Newbury Berkshire RG14 2FN verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASPECTIVE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| BUTLER, Janine | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 277534960001 | |||||||||
| YORSTON, Andrew Michael | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 257275320001 | |||||||||
| BANWELL, Michael John | Sekretär | Evadene Hogs Lodge Lane, Buster Hill PO8 0QA Waterlooville Hampshire | British | 84802540001 | ||||||||||
| BANWELL, Michael John | Sekretär | Evadene Hogs Lodge Lane, Buster Hill PO8 0QA Waterlooville Hampshire | British | 84802540001 | ||||||||||
| EMETULU, Lola | Sekretär | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire England | 128022980001 | |||||||||||
| GOCKELER, Martin | Sekretär | 18 Cherry Orchard Oakington CB4 5AY Cambridge | German | 54845870001 | ||||||||||
| HOWIE, Philip Robert Sutherland | Sekretär | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 77939460004 | ||||||||||
| KLINGER, Paul | Sekretär | Les Godaines George Road St Peter Port GY1 1BD Guernsey Channel Islands | British | 106221780001 | ||||||||||
| WRIGHT, Garth Howard | Sekretär | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire England | British | 130769810001 | ||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Geschäftsführer | Ogbourne St. George SN8 1TF Marlborough Og House Wiltshire | British | 123612980001 | ||||||||||
| ASKARI, Mamoun | Geschäftsführer | Flat 1 66 Cadogan Square SW1X 0EA London | British | 81751240001 | ||||||||||
| AZIZ, Javaid Khurshid, Dr | Geschäftsführer | Larksmead Titlarks Hill SL5 0JD Ascot Berkshire | England | English | 68624410001 | |||||||||
| BLEYLEBEN, Maximilian | Geschäftsführer | Flat 3 39 Queens Gardens W2 3AA London | Austrian | 102930160001 | ||||||||||
| BRYAN, Nicholas Martin | Geschäftsführer | Wynnwood Ballencrieff Road Sunningdale SL5 9RA Ascot Berkshire | British | 3625160001 | ||||||||||
| CARRATT, David Jonathan | Geschäftsführer | Glenridge Lodge Callow Hill GU25 4LF Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 22585710002 | |||||||||
| COSTELETOS, Phillipe Marinos | Geschäftsführer | 52 Kensington Place W8 7PR London | Greek | 74664800001 | ||||||||||
| EVANS, David Nigel | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||||||
| EVANS, Mark | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||||||
| HARRIS, Brian Athol | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom ( England ) (Gb-Eng) | Australian | 135937300001 | |||||||||
| IVES, Stephen Robert | Geschäftsführer | 4 Chequers Court Station Road CB4 5QJ Swavesey Cambs | United Kingdom | British | 166023200001 | |||||||||
| KELLY, Peter John Anthony | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 135004330001 | |||||||||
| LEE, Simon Christopher | Geschäftsführer | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||||||
| PURKESS, Martin John | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 139360020001 | |||||||||
| READ, Nicholas Jonathan | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||||||
| SAM, Johnnie | Geschäftsführer | Low Brooms 38 High Street Little Shelford CB2 5ES Cambridge Cambridgeshire | British | 39029170002 | ||||||||||
| SCHAFER, Richard Wolfgang Henry | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 187267490001 | |||||||||
| SKINNER, Robin David | Geschäftsführer | 5 Church Street Little Shelford CB2 5HG Cambridge Cambridgeshire | England | British | 67190020001 | |||||||||
| THOMSON, Terry | Geschäftsführer | 17 Latium Close Holywell Hill AL1 1XU St. Albans Hertfordshire | British | 67887420002 | ||||||||||
| TOURNON, Emanuele | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | 103542080002 | |||||||||
| TUNG, Savio | Geschäftsführer | 5 Gate House Road Scarsdale Ny 10583 Usa | American | 70321080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASPECTIVE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Uk Limited | 06. Apr. 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ASPECTIVE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 03. Juli 2003 Geliefert am 10. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £32,900 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £32,900. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 28. Sept. 2000 Geliefert am 06. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and erest thereon - details of charged deposit contract(s) - barclays bank PLC re aspective limited treasury deposit deal number 69746566. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Counterpart/rent deposit deed | Erstellt am 08. Juni 2000 Geliefert am 10. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee contained in a lease and an underlease both dated 8 june 2000 | |
Kurze Angaben All sums comprising the deposit placed in the account with the bankers (as defined in the deed) in accordance with clause 2.2 of the deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0