HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03870604 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 9 Brickfield Cottages Borehamwood Enterprise Centre Theobald Street WD6 4SD Borehamwood |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Nov. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 9 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Stirling Court Yard Stirling Way Borehamwood Hertfordshire WD6 2FX zum 9 Brickfield Cottages Borehamwood Enterprise Centre Theobald Street Borehamwood WD6 4SD am 30. Mai 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 22. März 2023 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 129 Stamford Hill London N16 5RR zum 3 Stirling Court Yard Stirling Way Borehamwood Hertfordshire WD6 2FX am 05. Apr. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 27. Nov. 2021 bis 31. Okt. 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Change of details for Mr David Margulies as a person with significant control on 03. März 2022 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Notification of Miriam Margulies as a person with significant control on 03. März 2022 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. März 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Mr David Margulies as a person with significant control on 03. März 2022 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Change of details for Mr David Margulies as a person with significant control on 10. Okt. 2021 | 2 Seiten | PSC04 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 27. Nov. 2020 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Apr. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 27. Nov. 2019 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 27. Nov. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 28. Nov. 2018 bis 27. Nov. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Nov. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Nov. 2017 bis 28. Nov. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGULIES, Joseph | Sekretär | Darenth Road Stamford N16 6ED London 82 | British | 4442590001 | ||||||
| MARGULIES, David | Geschäftsführer | Island House 47 -5 1 Portland Avenue N16 6EA London 1 United Kingdom | England | British | 132791250001 | |||||
| MARGULIES, Joseph | Geschäftsführer | Darenth Road Stamford N16 6ED London 82 | England | British | 4442590001 | |||||
| MARGULIES, Rachel | Geschäftsführer | Darenth Road N16 6ED London 82 | England | British | 4442580001 | |||||
| AA COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | First Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002630001 | |||||||
| BUYVIEW LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1st Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002620001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mrs Miriam Margulies | 03. März 2022 | Crowland Road N15 6UR London 103 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr David Margulies | 01. Juni 2016 | 47 -5 1 Portland Avenue, London N16 6EA London 1 Island House United Kingdom | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 23. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £243,445.00 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben 101 crowland road london fixed charge all fixtures fittings plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the property floating charge all other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which are from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 23. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £243,445.00 due or to become due from the company to | |
Kurze Angaben 103 crowland road london fixed charge all fixtures fittings plant and machinery which may from time to time be erected on or affixed to the property floating charge all other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which are from time to time on the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Apr. 2003 Geliefert am 30. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 22-26 woodgrange road london newham; EGL449341. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Apr. 2003 Geliefert am 07. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Nov. 2002 Geliefert am 05. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All those leasehold premises known as the upper part at 22-26 woodgrange road london E7 together with staircase leading to the ground floor to 1ST floor. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Nov. 2002 Geliefert am 05. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 23. Okt. 2001 Geliefert am 31. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Okt. 2001 Geliefert am 27. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that leasehold property known as flat 1 65 wood stret barnet london EN5 4BT title number AGL76866. First floating charge on all moveable plant machinery implements utensils furniture and equiptment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third party charge deed | Erstellt am 09. Nov. 2000 Geliefert am 16. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the loan offer and this charge deed | |
Kurze Angaben The l/h property k/a ground floor flat FLAT1 65 wood street in london borough of barnet t/n AGL76866 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale..assigned to the lender the related rights..fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery..floating charge the undertaking all property and assets..assigned the goodwill and the intellectual property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juni 2000 Geliefert am 04. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold land and buildings k/a the ranelagh arms 599 roman road in the london borough of tower hamlets t/n 161303. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Juni 2000 Geliefert am 27. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HILLSWICK INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0