CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03875121 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
- Transport über Rohrleitungen (49500) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 90 Whitfield Street W1T 4EZ London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRITISH SALT LIMITED | 07. Apr. 2000 | 07. Apr. 2000 |
| UK SALT HOLDINGS LIMITED | 10. März 2000 | 10. März 2000 |
| UK SALT LIMITED | 09. Dez. 1999 | 09. Dez. 1999 |
| INTERCEDE 1505 LIMITED | 11. Nov. 1999 | 11. Nov. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Paul Winkle als Geschäftsführer am 01. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matilda Jane Spencer als Geschäftsführer am 01. Nov. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Sept. 2019
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Change of details for Edf Energy Plc as a person with significant control on 03. Okt. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Anthony Winkle am 30. Apr. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Matthew Sykes am 09. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Harrison als Geschäftsführer am 06. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Anthony Winkle als Direktor am 06. Juni 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Matilda Jane Spencer als Direktor am 06. Juni 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von David Tomblin als Direktor am 05. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Fraser Mitchell als Geschäftsführer am 05. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Change of details for Edf Energy Plc as a person with significant control on 09. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gwen Susan Parry-Jones als Geschäftsführer am 22. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 40 Grosvenor Place Victoria London SW1X 7EN zum 90 Whitfield Street London W1T 4EZ am 09. Jan. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 15 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEBBINGTON, Christopher Andrew | Geschäftsführer | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | United Kingdom | British | 197462460001 | |||||
| SYKES, Matthew | Geschäftsführer | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | England | British | 119933330036 | |||||
| TOMBLIN, David | Geschäftsführer | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | England | British | 244241550001 | |||||
| CRAIG, Miranda Cathryn | Sekretär | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 | British | 139819800001 | ||||||
| DOLAN, Timothy Patrick | Sekretär | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Ks 66210 Usa | American | 69249930002 | ||||||
| MURPHY, Gerald Michael, Vice President | Sekretär | 14175 143rd St West Olathe Kansas 66062 Usa | Canadian | 99163520001 | ||||||
| THOMPSON, Christopher William | Sekretär | Halfpenny Barn Cranes Lane, Lathom L40 5UJ Ormskirk Lancashire | British | 114283730001 | ||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
| CHALLINOR, David | Geschäftsführer | Rosebank Marbury Road, Comberbach CW9 6AU Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 111045130001 | |||||
| DEMETREE, Mark Charles | Geschäftsführer | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Ks 66210 Usa | American | 69249840002 | ||||||
| DOLAN, Timothy Patrick | Geschäftsführer | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Ks 66210 Usa | American | 69249930002 | ||||||
| GALLAND, Jean Baptiste | Geschäftsführer | 44 Victoria Road W8 5RQ London | England | French | 110098880001 | |||||
| GUYLER, Robert | Geschäftsführer | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 | Scotland | British | 183996210001 | |||||
| HARRISON, Michael James | Geschäftsführer | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | United Kingdom | British | 202276140001 | |||||
| JONES, Robert Owen | Geschäftsführer | 7 Somerford Close CW11 1YL Sandbach Cheshire | United Kingdom | British | 103532410001 | |||||
| KUSTERER, Thomas Andreas | Geschäftsführer | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | United Kingdom | German | 137548090001 | |||||
| LORY, Ronan Emmanuel | Geschäftsführer | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 | United Kingdom | French | 163104520001 | |||||
| MCDERMOTT, Neil | Geschäftsführer | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | United Kingdom | British | 149077600001 | |||||
| MITCHELL, David Fraser | Geschäftsführer | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | England | British | 197462520001 | |||||
| MURPHY, Gerald | Geschäftsführer | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Kansas 66210 Usa | American | 69429470003 | ||||||
| PARRY-JONES, Gwen Susan | Geschäftsführer | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | United Kingdom | British | 187892980001 | |||||
| RICH, Michael William | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Hillfield Gorse Hill DA4 0JU Farningham Kent | British | 900015380001 | ||||||
| ROSSI, Simone | Geschäftsführer | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 United Kingdom | Uk | Italian | 159333940001 | |||||
| SHIH, Henry C Y | Geschäftsführer | 10955 Lowell Avenue Suite 600 Overland Park Kansas 66210 Usa | American | 69429520002 | ||||||
| SPENCER, Matilda Jane | Geschäftsführer | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | England | British | 244227590001 | |||||
| STEVEN, David Andrew, Dr | Geschäftsführer | Willow Bank Butchers Lane Aughton L39 6SY Ormskirk Lancashire | United Kingdom | British | 37384700001 | |||||
| THOMPSON, Christopher William | Geschäftsführer | Halfpenny Barn Cranes Lane, Lathom L40 5UJ Ormskirk Lancashire | England | British | 114283730001 | |||||
| WARNER, William | Geschäftsführer | 2 Honeysuckle Gardens CR0 8XU Croydon | British | 62351120001 | ||||||
| WINKLE, Anthony Paul | Geschäftsführer | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | Scotland | British | 270324580001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edf Energy Limited | 06. Apr. 2016 | Whitfield Street W1T 4EZ London 90 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHESHIRE CAVITY STORAGE GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Senior security deed of accession | Erstellt am 01. Jan. 2008 Erworben am 19. Juni 2009 Geliefert am 01. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mezzanine security deed of accession | Erstellt am 01. Jan. 2008 Erworben am 19. Juni 2009 Geliefert am 01. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debentures | Erstellt am 01. Jan. 2008 Erworben am 19. Juni 2009 Geliefert am 30. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/n CH428473. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission supplemental to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29/06/2007 and | Erstellt am 01. Jan. 2008 Geliefert am 09. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as british salt limited and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juni 2007 Erworben am 19. Juni 2009 Geliefert am 01. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mezzanine debenture | Erstellt am 29. Juni 2007 Erworben am 19. Juni 2009 Geliefert am 01. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land at hilltop farm school lane warmingham sandbach cheshire t/no CH428473. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 10. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the companys interest in the shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share charge | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 10. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the companys interest in the shares and the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 07. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 07. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 07. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Juni 2007 Geliefert am 05. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the security trustee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Aug. 2004 Geliefert am 03. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land k/a hole house farm minshull vernon t/no CH441867, f/h land on the north side of cledford lane and land at faulkner drive middlewich t/no CH292747, f/h mines, minerals, salt, salt rock and brine under the land at parkfields farm minshull vernon middlewich t/no CH455194 (for further details of properties charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 26. Sept. 2002 Geliefert am 30. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation 10100051 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Apr. 2000 Geliefert am 26. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The prompt performance and observance by the company formerly known as UK salt holdings limited of all the UK obligations (as defined) together with all costs,charges and expenses incurred by the bank of america international limited acting in its capacity as agent and trustee for and on behalf of the agents and the lenders in the protection,preservation and enforcement of their respective rights in relation thereto | |
Kurze Angaben First legal mortgage over land on the north side of cledford land and land at faulkner drive, middlewich t/no.CH292747; hilltop farm, warmingham road, warmingham t/no.CH428473; hole house farm, minshull vernon t/no.CH441867.please refer to form 395 for full property details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0