HOLLINGER UK HOLDINGS

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHOLLINGER UK HOLDINGS
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital
    Unternehmensnummer 03877601
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HOLLINGER UK HOLDINGS?

    • (7415) /

    Wo befindet sich HOLLINGER UK HOLDINGS?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HOLLINGER UK HOLDINGS?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OLMY LIMITED16. Nov. 199916. Nov. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOLLINGER UK HOLDINGS?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2003

    Welche sind die letzten Einreichungen für HOLLINGER UK HOLDINGS?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Juni 2010

    Kapitalaufstellung am 07. Juni 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von HOLLINGER UK HOLDINGS?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCDONOUGH, James
    2300 West Armitage Avenue
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60647
    United States
    Sekretär
    2300 West Armitage Avenue
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60647
    United States
    U.S. Citizen117763570001
    KRAM, Thomas
    2542 Rourke Drive
    Aurora
    Illinois
    60503
    United States
    Geschäftsführer
    2542 Rourke Drive
    Aurora
    Illinois
    60503
    United States
    UsaAmerican139531870001
    MCDONOUGH, James
    2300 West Armitage Avenue
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60647
    United States
    Geschäftsführer
    2300 West Armitage Avenue
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60647
    United States
    U.S. Citizen117763570001
    DAVIES, Alan John
    5 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BN Sevenoaks
    Kent
    Sekretär
    5 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BN Sevenoaks
    Kent
    British43528130002
    GRIFFITHS, Sally Jane
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    Sekretär
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    British91601070001
    VAN HORN, James R
    41 Normandie Place
    07016 Cranford
    New Jersey
    Usa
    Sekretär
    41 Normandie Place
    07016 Cranford
    New Jersey
    Usa
    Us Citizen127973690001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BARKER III, William
    1612a N. Mohawk
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60614
    United States
    Geschäftsführer
    1612a N. Mohawk
    FOREIGN Chicago
    Illinois 60614
    United States
    U.S. Citizen120001190001
    BLACK, Conrad Moffat, Lord
    14 Cottesmore Gardens
    W8 5PR London
    Geschäftsführer
    14 Cottesmore Gardens
    W8 5PR London
    British Canadian28193100004
    COLSON, Daniel William
    19 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Geschäftsführer
    19 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Canadian47403810003
    COLSON, Daniel William
    19 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Geschäftsführer
    19 Hanover Terrace
    NW1 4RJ London
    Canadian69103050001
    DAVIES, Alan John
    5 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BN Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    5 Uplands Way
    Riverhead
    TN13 3BN Sevenoaks
    Kent
    British43528130002
    GRIFFITHS, Sally Jane
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    83 Brian Avenue
    CR2 9NJ South Croydon
    Surrey
    British91601070001
    HEALY, Paul Brian
    210 West 90th Street
    Apt 7j
    New York
    Ny 10024
    America
    Geschäftsführer
    210 West 90th Street
    Apt 7j
    New York
    Ny 10024
    America
    United StatesAmerican205407480001
    O'DONNELL KEENAN, Niamh
    142 Hampstead Way
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 7XH London
    Geschäftsführer
    142 Hampstead Way
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 7XH London
    Great BritainIrish57325730001
    PARIS, Gordon A
    7 Mt Holly Drive
    Rye
    Ny 10580
    America
    Geschäftsführer
    7 Mt Holly Drive
    Rye
    Ny 10580
    America
    Us Citizen96298180001
    SMITH, Robert
    194 Fairmont Avenue
    Chatham
    Nj 07928
    Usa
    Geschäftsführer
    194 Fairmont Avenue
    Chatham
    Nj 07928
    Usa
    U S Citizen96296370001
    STOKLOSA, Gregory
    1021 Forest Avenue
    Evanston
    Illinois 60202
    United States
    Geschäftsführer
    1021 Forest Avenue
    Evanston
    Illinois 60202
    United States
    U S Citizen117762260001
    VAN HORN, James R
    41 Normandie Place
    07016 Cranford
    New Jersey
    Usa
    Geschäftsführer
    41 Normandie Place
    07016 Cranford
    New Jersey
    Usa
    UsaUs Citizen127973690001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Hat HOLLINGER UK HOLDINGS Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture creating fixed and floating charges
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 08. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations due or to become due from the charging company to any of the secured parties and/or any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wachovia Bank,N.A.as Security Trustee
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    UK subsidiary guaranty dated 23RD december, 2002 between the guarantor, deedtask limited, creditscheme limited, dt holdings limited, second dt holdings limited (the "additional guarantors") in favour of the secured parties and wachovia bank, N.A. as administrative agent for the lenders (the "U.K. guarantee")
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 08. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any and all balances, credits, deposits, accounts or moneys of the guarantor then or thereafter maintained with the administrative agent or such other secured party and any and all property of every kind or description of or in the name of the guarantor now or hereafter, for any reason or purpose whatsoever, in the possession or control of, or in transits to, the administrative agent or, such other secured party or any agent or bailee therefore.
    Berechtigte Personen
    • Wachovia Bank, N.A.
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture (as defined)
    Erstellt am 01. Juni 2000
    Geliefert am 07. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations (monetary or otherwise) of the company howsoever due or to become due to the chargee in connection with the U.K. newco subsidiary guaranty, the debenture,any other loan document or any other document or instrument (including any hedging agreement) as defined
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Toronto Dominion (Texas),Inc.as Administrative Agent for the Lenders
    Transaktionen
    • 07. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second supplemental deed (to the deed of charge & memorandum of depopsit dated 7/4/97 as amended by the first supplemental deed between toronto dominion (texas), inc. (The administrative agent), hollinger UK holdings limited (the depositor) & hollinger international publishing inc. (The company) dated 8/3/00 (the second supplemental deed to the telegrpah pledge agreement))
    Erstellt am 08. März 2000
    Geliefert am 17. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations (monetary or otherwise) of the "depositor" howsoever created, arising or evidenced, whether direct or indirect, absolute or contingent, existing on or after 7 april 1997 or due or to become due which arise out of or in connection with in the case of hollinger international publishing inc. (The "company") the amended and restated credit agreement and, in the case of the "depositor" the UK newco subsidiary guaranty and in the case of the "depositor" and hollinger international publishing inc. (The "company") the charge and memorandum (as amended) (the "amended charge and memorandum"), any other loan document or any document or instrument executed in connection therewith (including any hedging agreement entered into with any person who at the time such hedging agreement is entered into is a lender or an affiliate thereof) (the "liabilities")
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the following: all of the shares described in schedule I to the second supplemental deed to the telegraph pledge agreement listed under the depositor's name, and all cash securities dividends in respect thereof.. The "securities". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Toronto Dominion (Texas), Inc. (as Administrative Agent for the Lenders)
    Transaktionen
    • 17. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second supplemental deed (to the deed of charge and memorandum of depopsit dated 7 april 1997 as amended by the first supplemental deed (the charge and memorandum) between toronto dominion (texas), inc. (The administrative agent), first dt holdings limited, dt holdings limited & hollinger UK holdings limited (the depositor) dated 8 march 2000 (the second supplemental deed)
    Erstellt am 08. März 2000
    Geliefert am 17. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations (monetary or otherwise) of the "depositor" howsoever created, arising or evidenced, whether direct or indirect, absolute or contingent, existing on or after 7 april 1997 or due or to become due which arise out of or in connection with, the case of the "depositor", the UK newco subsidiary guaranty, in the case of first dt holdings limited and dt holdings limited, the UK subsidiary guaranty and in the case of the "depositor", first dt holdings limited and dt holdings limited, the charge and memorandum (as amended) (the "amended charge and memorandum"), any other loan document or any document or instrument executed in connection therewith (including any hedging agreement entered into with any person who at the time such hedging agreement is entered into is a lender or an affiliate thereof) (the "liabilities")
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the following: all of the shares described in schedule I to the amended charge and memorandum listed under the depositor's name, and all cash securities dividends in respect thereof.. The "securities". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Toronto Dominion (Texas), Inc. (as Administrative Agent for the Lenders)
    Transaktionen
    • 17. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0