CHIPPENHAM OFFICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHIPPENHAM OFFICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03880722 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHIPPENHAM OFFICES LIMITED?
- (7032) /
Wo befindet sich CHIPPENHAM OFFICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o SECRETARIAT SERVICES LIMITED 17 MONKS BROOK INDUSTRIAL ESTATE School Close Chandlers Ford SO53 4RA Eastleigh |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHIPPENHAM OFFICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHIPPENHAM OFFICES AND HOUSING LIMITED | 16. Nov. 1999 | 16. Nov. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHIPPENHAM OFFICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHIPPENHAM OFFICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Secretariat Services Limited am 16. Mai 2011 | 3 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Directorate Services Limited am 16. Mai 2011 | 3 Seiten | CH02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Meridian House, the Crescent York North Yorkshire YO24 1AW am 27. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Directorate Services Limited am 21. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Secretariat Services Limited am 21. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2011 bis 31. Dez. 2010 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Shaun Francis Cummings am 18. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2005 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHIPPENHAM OFFICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | c/o Directorate Services Limited 17 Monks Brook Industrial Estate Chandlers Ford SO53 4RA Eastleigh School Close |
| 70053320013 | ||||||||||
| CUMMINGS, Shaun Francis | Geschäftsführer | c/o Secretariat Services Limited 17 Monks Brook Industrial Estate Chandlers Ford SO53 4RA Eastleigh School Close | United Kingdom | British | 46340470001 | |||||||||
| DIRECTORATE SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | c/o Secretariat Services Limited 17 Monks Brook Industrial Estate Chandlers Ford SO53 4RA Eastleigh School Close |
| 103992880001 | ||||||||||
| BIRCH, Alan Edward | Geschäftsführer | 7 Silsbury Grove Standish WN6 0EY Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 90700330001 | |||||||||
| GARDINER, Patrick Hugh | Geschäftsführer | Greystones Cornsland CM14 4JL Brentwood Essex | British | 63883470001 | ||||||||||
| GORDON, Ray | Geschäftsführer | 29 Carrs Meadow Escrick YO19 6JZ York North Yorkshire | British | 102379260001 | ||||||||||
| JOHNSON, Robert Nigel | Geschäftsführer | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | 57954340003 | |||||||||
| LAFFERTY, Henry | Geschäftsführer | Windmill House 4 High Street MK44 1PG Sharnbrook Beds | England | British | 146249130001 | |||||||||
| LAIRD, Stuart Wilson | Geschäftsführer | Fir Tree Farmhouse Fir Tree Lane Horton Heath SO50 7DF Eastleigh Hampshire | England | British | 60742240002 | |||||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Geschäftsführer | Downing House Lower Road SG8 0EG Croydon Royston Cambridgeshire | United Kingdom | British | 37404250003 | |||||||||
| SUTTON, Andrew John | Geschäftsführer | Browns End Cottage Browns End Road CM6 2BE Broxted Essex | United Kingdom | British | 110729740001 | |||||||||
| WALLACE, Robert Anthony | Geschäftsführer | 1 Castlereagh Wynyard TS22 5QF Billingham Cleveland | England | British | 57589480001 | |||||||||
| WESTBROOK, Bernard Leslie | Geschäftsführer | 4 Quantock Close Barton Seagrave NN15 6RR Kettering Northamptonshire | England | British | 51336870001 |
Hat CHIPPENHAM OFFICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Minimum payments account charge | Erstellt am 13. Nov. 2001 Geliefert am 21. Nov. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the charge and under the receivables financing documents and/or any deed or document supplemental thereto | |
Kurze Angaben Fixed charge its whole right title interest and benefit in the minimum payments account and the debt represented thereby and all interest, the cash collateral and all rights relative thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of cash deposit | Erstellt am 19. Apr. 2000 Geliefert am 09. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility agreement dated on or about the date of the mortgage and as amended,varied or supplemented | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit (as defined) and any credit balance or any deposit on the accounts (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture (supplemental facility) | Erstellt am 19. Apr. 2000 Geliefert am 09. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the supplemental facility letter dated on or about the date of the debenture relating to a loan facility of up to £25,000 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Apr. 2000 Geliefert am 09. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben The land known as monkton park offices and land adjoining monkton hill,chippenham. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of contract rights | Erstellt am 19. Apr. 2000 Geliefert am 09. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facilities agreement (as defined) dated on or about the date of the assignment | |
Kurze Angaben All right,title and interest in and the full benefit of each of the contracts (as defined) and all other rights/benefits whatsoever in respect of amounts received or accruing to the company thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0