CHEMICARE HEALTH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHEMICARE HEALTH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03881748
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHEMICARE HEALTH LIMITED?

    • Apotheken in spezialisierten Geschäften (47730) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich CHEMICARE HEALTH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHEMICARE HEALTH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Jan. 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHEMICARE HEALTH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 28. Juni 2013

    • Kapital: GBP 4
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2013

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Michael Peter Blakeman am 28. Nov. 2011

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Jonathan Smith am 28. Nov. 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2011

    4 SeitenAA

    Ernennung von Mr Kevin Robert Hudson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Joseph Penn als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2010

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2008

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2007

    21 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von CHEMICARE HEALTH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BLAKEMAN, Michael Peter
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Sekretär
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    British126522990002
    HUDSON, Kevin Robert
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    EnglandBritish69091720002
    SMITH, Paul Jonathan
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    WalesBritish63118770002
    GOULT, David Alexander
    8 Dawpool Drive
    Moreton
    CH46 0PH Wirral
    Merseyside
    Sekretär
    8 Dawpool Drive
    Moreton
    CH46 0PH Wirral
    Merseyside
    British84910240001
    SAWBRIDGE, Gary
    Wood Corner
    Brookledge Road
    SK10 4JX Adlington
    Cheshire
    Sekretär
    Wood Corner
    Brookledge Road
    SK10 4JX Adlington
    Cheshire
    British119400170002
    GEORGE DAVIES (NOMINEES) LIMITED
    Fountain Court
    68 Fountain Street
    M2 2FB Manchester
    Greater Manchester
    Sekretär
    Fountain Court
    68 Fountain Street
    M2 2FB Manchester
    Greater Manchester
    67628560001
    BURROWS, Peter
    Red Rock Farmhouse
    Red Rock Lane
    WN1 2UW Haigh Wigan
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    Red Rock Farmhouse
    Red Rock Lane
    WN1 2UW Haigh Wigan
    Greater Manchester
    British89658150001
    COLLINS, Mark
    125 Park Road
    Prestwich
    M25 0DU Manchester
    Geschäftsführer
    125 Park Road
    Prestwich
    M25 0DU Manchester
    British48777060001
    MOLYNEUX, Martin
    The East Barn Arley Farm
    3 Arley Lane Haigh
    WN1 2UJ Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The East Barn Arley Farm
    3 Arley Lane Haigh
    WN1 2UJ Wigan
    Lancashire
    British85215590001
    PENN, Joseph Jonathan
    Field House Lodge
    Mannings Lane Hoole Village
    CH2 4EU Chester
    Geschäftsführer
    Field House Lodge
    Mannings Lane Hoole Village
    CH2 4EU Chester
    United KingdomBritish16365120018
    SAWBRIDGE, Gary
    Wood Corner
    Brookledge Road
    SK10 4JX Adlington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Wood Corner
    Brookledge Road
    SK10 4JX Adlington
    Cheshire
    United KingdomBritish119400170002
    TURNER, David William
    17 Hawkridge Close
    West Houghton
    BB5 2GP Bolton
    Geschäftsführer
    17 Hawkridge Close
    West Houghton
    BB5 2GP Bolton
    British54196220002

    Hat CHEMICARE HEALTH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 01. Aug. 2005
    Geliefert am 13. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property comprising the ground floor and basement at 6 canute place knutsford,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Mai 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 6 wood street, st annes-on-sea. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juli 2004
    Geliefert am 07. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 hallfields road orford warrington cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Okt. 2002
    Geliefert am 08. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    331 norris road sale. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Okt. 2002
    Geliefert am 04. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    198 briercliffe road burnley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2001
    Geliefert am 05. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    104 sale road northern moor manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2001
    Geliefert am 05. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    15 market street adlington chorley lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 01. Nov. 2001
    Geliefert am 01. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation 10509835 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Sept. 2000
    Geliefert am 13. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 14 elswick road preston lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Mai 2000
    Geliefert am 17. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as land and buildings at 391 manchester road astley wigan greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. März 2000
    Geliefert am 04. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 4 and 4A parkgate lane knutsford.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 2000
    Geliefert am 29. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0