E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED

E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameE.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03883559
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED?

    • (1120) /

    Wo befindet sich E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hill House 1
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CALEDONIA CAISTER LIMITED07. Nov. 200307. Nov. 2003
    CONSORT CAISTER LIMITED23. Dez. 199923. Dez. 1999
    BURGINHALL 1145 LIMITED25. Nov. 199925. Nov. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Aufschub der Auflösung (freiwillig)

    1 SeitenCOLIQ

    Insolvenzbeschluss

    Resolution INSOLVENCY:Special resolution :- "Books,Records.etc"
    1 SeitenLIQ MISC RES

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 22. Dez. 2009

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Davis House 7th Floor 129 Wilton Road London SW1V 1JZ am 30. Dez. 2009

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Judith Buss als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    23 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    20 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LERCH, Michael Felix
    Heathside Park Road
    GU22 7JF Woking
    White Gates
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Heathside Park Road
    GU22 7JF Woking
    White Gates
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomGerman139096860001
    ASHMORE, Richard John
    14 Willowmead Close
    Ealing
    W5 1PT London
    Sekretär
    14 Willowmead Close
    Ealing
    W5 1PT London
    British84884080001
    BATE, Christopher Malcolm
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    Sekretär
    Bryn Y Mor
    LL57 2HG Bangor
    Gwynedd
    British77942170001
    GRAY'S INN SECRETARIES LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Bevollmächtigter Sekretär
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002550001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Sekretär
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    BELL, Andrew Stewart
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    Geschäftsführer
    178 Clonmore Street
    SW18 5HB London
    United KingdomBritish95066820001
    BENKE, Eike, Dr
    Kantorie 89 D-45134
    FOREIGN Essen
    Germany
    Geschäftsführer
    Kantorie 89 D-45134
    FOREIGN Essen
    Germany
    German32474820002
    BUSS, Judith
    24 Hardstrasse
    D-40629
    Dusseldorf
    Germany
    Geschäftsführer
    24 Hardstrasse
    D-40629
    Dusseldorf
    Germany
    German126797980001
    COLE, Martin
    15 Cuddington Park Close
    SM7 1RF Banstead
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Cuddington Park Close
    SM7 1RF Banstead
    Surrey
    British59419030002
    EDGLEY, Steven Neville
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    83 Loom Lane
    WD7 8NY Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritish85718530001
    FERGUSON, Donald
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    Geschäftsführer
    6 Cresswell Gardens
    Kensington
    SW5 0BJ London
    British88767730001
    GROOM, Malcolm David John
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Westlodge
    169 Burwood Road
    KT12 4AT Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29602720001
    HAWKINS, Warren
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    Geschäftsführer
    4225 Milton
    Houston
    Harris Texas
    77005
    Usa
    American94520330001
    HOGAN, John Anthony
    The Malthouse Heaverham Road
    Kemsing
    TN15 6NE Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    The Malthouse Heaverham Road
    Kemsing
    TN15 6NE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish94257040001
    HONEYBOURNE, John William Gervase
    614 Regentview Drive
    Houston
    Texas
    77079
    U S A
    Geschäftsführer
    614 Regentview Drive
    Houston
    Texas
    77079
    U S A
    UsaBritish94265940001
    HUNTER, Alexander
    64 Contlaw Road
    Milltimber
    AB13 0EJ Aberdeen
    Geschäftsführer
    64 Contlaw Road
    Milltimber
    AB13 0EJ Aberdeen
    British73259250003
    LEGG, Jonathan Victor Lewis
    188a Sutherland Avenue
    W9 1HR London
    Geschäftsführer
    188a Sutherland Avenue
    W9 1HR London
    United KingdomBritish67082340002
    MACAULAY, William E.
    7 Hill Road
    Greenwich
    06830 Connecticut
    Usa
    Geschäftsführer
    7 Hill Road
    Greenwich
    06830 Connecticut
    Usa
    United StatesAmerican238080500001
    MACDONALD, Jeffrey Saunders
    18114 Langsbury Drive
    Houston
    Texas
    77084
    Usa
    Geschäftsführer
    18114 Langsbury Drive
    Houston
    Texas
    77084
    Usa
    British87467740001
    MARIS, Antony Wayne
    16 Brighton Road
    GU7 1NS Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    16 Brighton Road
    GU7 1NS Godalming
    Surrey
    EnglandBritish78957850001
    MURCHISON, John Hardy
    6200 Burgoyne Road
    77057 Houston
    Texas
    Usa
    Geschäftsführer
    6200 Burgoyne Road
    77057 Houston
    Texas
    Usa
    American88904040001
    PRIEN, Nicolo
    Oberkasseler Strasse 64
    Duesseldorf
    40545
    Germany
    Geschäftsführer
    Oberkasseler Strasse 64
    Duesseldorf
    40545
    Germany
    German108803940001
    PRINGLE, Keith James
    The Nelmes
    Munsley
    HR8 2SH Ledbury
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    The Nelmes
    Munsley
    HR8 2SH Ledbury
    Herefordshire
    UkUk61942150003
    REICHETSEDER, Peter, Prof Dr
    Tippelstr. 100
    45529
    Hattingen
    Germany
    Geschäftsführer
    Tippelstr. 100
    45529
    Hattingen
    Germany
    Austrian93247640002
    ROTHERMUND, Heinz Charles
    Aufdorfstrasse
    Mannedorf
    146
    Ch 8708
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Aufdorfstrasse
    Mannedorf
    146
    Ch 8708
    Switzerland
    Swiss122144690001
    SHAW, Sandra Nan Demby
    21 Harcourt Road
    SL6 0DT Dorney Reach
    Berkshire
    Geschäftsführer
    21 Harcourt Road
    SL6 0DT Dorney Reach
    Berkshire
    EnglandBritish78957930001
    SIVERTSEN, Frank Allan
    Fjellfruebakken
    N-4070 Randaberg
    2
    Norway
    Geschäftsführer
    Fjellfruebakken
    N-4070 Randaberg
    2
    Norway
    Norwegian109251340002
    WEBSTER, Steven
    1908 River Oaks Blvd.
    Houston
    Harris 77019
    United States
    Geschäftsführer
    1908 River Oaks Blvd.
    Houston
    Harris 77019
    United States
    American113330320001
    WILLIS, John Kingsley
    32 Mount Hermon Road
    GU22 7UN Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    32 Mount Hermon Road
    GU22 7UN Woking
    Surrey
    British63117390001
    DH & B DIRECTORS LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002540001
    DH & B MANAGERS LIMITED
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    5 Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900002530001

    Hat E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Second-ranking borrowing base asset security agreement
    Erstellt am 24. Nov. 2004
    Geliefert am 07. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the undeveloped asset backed finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second-ranking undeveloped asset backed security agreement
    Erstellt am 24. Nov. 2004
    Geliefert am 07. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First-ranking undeveloped asset backed security agreement
    Erstellt am 24. Nov. 2004
    Geliefert am 07. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) as agent and trustee for the undeveloped asset backed finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 23. Okt. 2003
    Geliefert am 12. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as consort caister limited to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of an equitable mortgage all shares in any member of the group, by way of a floating charge its interest in all shares stocks debentures bonds or other securities owned by it or held by any nominee on its behalf.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Trustee Fore Itself and the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 12. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Feb. 2001
    Geliefert am 13. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined) to which the company is a party
    Kurze Angaben
    Fixed charge all of the assigned assets, all group shares and related rights accruing to the group shares. Floating charge all its undertaking and assets (all terms defined therein).
    Berechtigte Personen
    • Txu Europe Group PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Feb. 2001
    Geliefert am 16. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dynergy Marketing and Trading Sarl
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 07. Feb. 2001
    Geliefert am 15. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company to any finance party under each finance document to which the company is a party (and for the avoidance of doubt the term finance document includes all amendments and supplements including supplements providing for further advances)
    Kurze Angaben
    1) assignment all of the assigned assets except in the case of any rights under any project documents. 2) the fixed charge over all of the assigned assets to the extent (if any) not effectively assigned under clause 2.1 (assignment) of the security agreement. All group shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights accruing to the group shares; and all property specified in schedule 1 to the security agreement. 3) floating charge all its undertaking and assets both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Facility Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Juni 2000
    Geliefert am 11. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Under the security agreement 1, assignment assigns and agrees to assign to the agent all of the assigned assets except in the case of any rights under any project document to the (if any) that a valid assignment of the rights by the security agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat E.ON RUHRGAS UK CAISTER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Feb. 2011Aufgelöst am
    22. Dez. 2009Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicholas James Dargan
    Deloitte & Touche
    Po Box 810, Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Praktiker
    Deloitte & Touche
    Po Box 810, Athene Place
    EC4A 3WA 66 Shoe Lane
    London
    Christopher Richard Frederick Day
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praktiker
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0