RETAIL DECISIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | RETAIL DECISIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03885583 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RETAIL DECISIONS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich RETAIL DECISIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 10-18 Union Street SE1 1SZ London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RETAIL DECISIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
RETAIL DECISIONS PLC | 24. Nov. 1999 | 24. Nov. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RETAIL DECISIONS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RETAIL DECISIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Insolvenzmeldung Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl | 4 Seiten | LIQ MISC | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 15 Seiten | LIQ10 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Red House Brookwood Woking Surrey GU24 0BL zum 10-18 Union Street London SE1 1SZ am 21. Juli 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Fabio Massimo Giuseppetti am 26. Okt. 2014 | 4 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. Sept. 2014
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neshia Michelle Ali als Sekretär am 11. Sept. 2014 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Sept. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Robert Stanley als Geschäftsführer am 12. Aug. 2014 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neshia Michelle Ali als Geschäftsführer am 12. Aug. 2014 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Ernennung von Ricardo Caupers als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RETAIL DECISIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUPERS, Ricardo | Geschäftsführer | King Street SW1Y 6RT London 33 United Kingdom | United Kingdom | Portuguese | Partner | 188764420001 | ||||
GIUSEPPETTI, Fabio Massimo | Geschäftsführer | Union Street SE1 1SZ London 10-18 United Kingdom | United Kingdom | Italian | Partner In Private Equity F | 115927050001 | ||||
ALI, Neshia Michelle | Sekretär | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey | 165337440001 | |||||||
AMOS, Richard John | Sekretär | 22 Collens Road AL5 2AJ Harpenden Hertfordshire | British | Finance Director | 67950460002 | |||||
DRYSDALE, Clive Douglas | Sekretär | The Hollies Bath Road SL6 4LH Maidenhead Berkshire | British | Group Finance Director | 45345090004 | |||||
GOOD, Thomas William | Sekretär | 5 Burnet Close GU24 9PB West End Surrey | British | Accountant | 21310620004 | |||||
HAYES, Kevin Andrew | Sekretär | 4 Elm Road SO22 5AG Winchester Hampshire | British | Director | 29737760001 | |||||
HAYES, Kevin Andrew | Sekretär | 4 Elm Road SO22 5AG Winchester Hampshire | British | Accountant | 29737760001 | |||||
ALI, Neshia Michelle | Geschäftsführer | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey | United Kingdom | British | Director | 164289480001 | ||||
AMOS, Richard John | Geschäftsführer | 22 Collens Road AL5 2AJ Harpenden Hertfordshire | England | British | Accountant | 67950460002 | ||||
CAUNTER, Nicholas John | Geschäftsführer | Appletrees 7 Lashmere Copthorne RH10 3RR Crawley West Sussex | British | Director | 100149070001 | |||||
CLUMP, Carlyle Cyril | Geschäftsführer | Block 11 Portomaso PTM 01 St Julians Apartment 1112 Malta | Malta | British | Director | 61613210002 | ||||
DRYSDALE, Clive Douglas | Geschäftsführer | The Hollies Bath Road SL6 4LH Maidenhead Berkshire | England | British | Group Finance Director | 45345090004 | ||||
GEIN, Robert Allen | Geschäftsführer | 108 Conover Lane Red Bank FOREIGN New Jersey 07701 Usa | American | Company Director | 67593770001 | |||||
GOOD, Thomas William | Geschäftsführer | 5 Burnet Close GU24 9PB West End Surrey | British | Accountant | 21310620004 | |||||
HUGAS, Jaime-Enrique | Geschäftsführer | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey | United Kingdom | Spanish | Director | 133105830001 | ||||
PARSONS, Robert Michael Featherstonehaugh | Geschäftsführer | Three Hills House Epwell OX15 6LG Banbury Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 51846740001 | ||||
STANLEY, Paul Robert | Geschäftsführer | Red House Brookwood GU24 0BL Woking Surrey | England | British | Director | 165600110001 | ||||
TILLY, Edward Arthur | Geschäftsführer | Woodlands Bishops Walk CR0 5BA Croydon | England | British | Insurance Executive | 46579720001 | ||||
TOZER, Jane Elizabeth | Geschäftsführer | 10 Little Hill Herons Gate WD3 5BX Chorleywood Hertfordshire | England | British | Director | 13471130001 | ||||
TURNER, Matthew Charles | Geschäftsführer | Springfield Hall Star Lane Knowl Hill RG10 9UR Reading Berkshire | United Kingdom | British | Partner In Private Equity F | 115927000001 | ||||
VAUGHAN, Oliver John | Geschäftsführer | 20 Phillimore Gardens W8 7QE London | England | British | Director | 3418760001 | ||||
WESTMORE, Geoffrey David | Geschäftsführer | Staple Inn Buildings South Holborn WC1V 7PZ London | England | British | Director | 10280940003 | ||||
WHITTAKER, Nigel | Geschäftsführer | 176 Bickenhall Mansions Bickenhall Street W1U 3BU London | British | 65180900001 |
Hat RETAIL DECISIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 26. Mai 2011 Geliefert am 02. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 07. Jan. 2008 Geliefert am 12. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits now and in the future credited to account designation nxnfkxkw-EUR00 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An accession deed | Erstellt am 23. Feb. 2007 Geliefert am 15. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all real property by way of first fixed charge all shares all dividends interest sand other monies and each of its accounts by way of assignment the proceeds of any claim under any insurance policy and all related rights and all rights and claims in relation to any assigned account by way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Nov. 2005 Geliefert am 18. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Legal mortgage its interest in the land,fixed charge any right,title or interest in any other land,all shares and all related distribution rights,all investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture made between the company and national westminster bank PLC (the security trustee) | Erstellt am 11. Jan. 2000 Geliefert am 17. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whether present and future, actual or contingent due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat RETAIL DECISIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0