NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03891027 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 87-91 Newman Street London W1T 3EY |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MERCURY HEALTHCARE LIMITED | 09. Mai 2006 | 09. Mai 2006 |
NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED | 28. Sept. 2004 | 28. Sept. 2004 |
TRIBAL TRAINING LIMITED | 01. Sept. 2004 | 01. Sept. 2004 |
NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED | 09. Dez. 1999 | 09. Dez. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Ernennung von Miss Lorraine Anne Davis als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Collins als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 23 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Derrick Breach als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Lawton als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter John Martin am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Marcus Lawton am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Richard Hawke Collins am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed mercury healthcare LIMITED\certificate issued on 11/12/06 | 2 Seiten | CERTNM |
Wer sind die Geschäftsführer von NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIS, Lorraine Anne | Sekretär | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | 150956230001 | |||||||
BREACH, Stephen Derrick | Geschäftsführer | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | Finance Director | 147928530001 | ||||
MARTIN, Peter John | Geschäftsführer | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | Director | 176044430001 | ||||
COLLINS, Richard Hawke | Sekretär | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | British | 53398040001 | ||||||
DICKIE, Norman Alexander | Sekretär | 281 Staplegrove Road TA2 6AL Taunton Somerset | British | Company Director | 103846000001 | |||||
LAWTON, Simon Marcus | Sekretär | Long Ash Woodbridge Lane Withington GL54 4BP Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 68807890004 | |||||
SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
DICKIE, Norman Alexander | Geschäftsführer | 281 Staplegrove Road TA2 6AL Taunton Somerset | United Kingdom | British | Company Director | 103846000001 | ||||
HILL, Martin | Geschäftsführer | Parsonage Farm Parsonage Lane Kingston St Mary TA2 8HL Taunton Somerset | England | British | Company Director | 43510870003 | ||||
LAWTON, Simon Marcus | Geschäftsführer | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | Director | 68807890004 | ||||
PITMAN, Henry John | Geschäftsführer | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | Company Director | 55231490005 | ||||
TREMBATH, Christopher Richard | Geschäftsführer | 26 Mariners Drive Sneyd Park BS9 1QQ Bristol | United Kingdom | British | Company Director | 77436880002 | ||||
CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 |
Hat NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Juni 2007 Geliefert am 21. Juni 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture made between certain subsidiaries of tribal group PLC and the governor and company of the bank of scotland | Erstellt am 13. Dez. 2002 Geliefert am 24. Dez. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of each group company to the security trustee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 17. Okt. 2002 Geliefert am 23. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture between the company and the south place gresham partnership 2000 (the "trustee") | Erstellt am 22. Sept. 2000 Geliefert am 06. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All or any monies and liabilities which shall for the time being (and whether on or at any time after demand) be due, owing or incurred in whatsoever manner by the principal to any noteholder under or in respect of any designated loan note or any other secured party whether actually or contingently and whether incurred solely, severally or jointly and whether as principal or surety and whether on account of any money advanced, bills of exchange, promissory notes, guarantees, indemnities or otherwise, including interest, discount, commission and other lawful charges or expenses with such secured party may in the course of its business charge or incur together with costs expenses and interest | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Sept. 2000 Geliefert am 09. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0