NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED

NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03891027
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MERCURY HEALTHCARE LIMITED09. Mai 200609. Mai 2006
    NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED28. Sept. 200428. Sept. 2004
    TRIBAL TRAINING LIMITED01. Sept. 200401. Sept. 2004
    NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED09. Dez. 199909. Dez. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Ernennung von Miss Lorraine Anne Davis als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Richard Collins als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    23 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Ernennung von Mr Stephen Derrick Breach als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Simon Lawton als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Dez. 2009

    Kapitalaufstellung am 09. Dez. 2009

    • Kapital: GBP 207
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Peter John Martin am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Marcus Lawton am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Richard Hawke Collins am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    7 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353a

    legacy

    1 Seiten353a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    9 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten363a

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed mercury healthcare LIMITED\certificate issued on 11/12/06
    2 SeitenCERTNM

    Wer sind die Geschäftsführer von NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIS, Lorraine Anne
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Sekretär
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    150956230001
    BREACH, Stephen Derrick
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Geschäftsführer
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    United KingdomBritishFinance Director147928530001
    MARTIN, Peter John
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Geschäftsführer
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritishDirector176044430001
    COLLINS, Richard Hawke
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Sekretär
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    British53398040001
    DICKIE, Norman Alexander
    281 Staplegrove Road
    TA2 6AL Taunton
    Somerset
    Sekretär
    281 Staplegrove Road
    TA2 6AL Taunton
    Somerset
    BritishCompany Director103846000001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector68807890004
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    DICKIE, Norman Alexander
    281 Staplegrove Road
    TA2 6AL Taunton
    Somerset
    Geschäftsführer
    281 Staplegrove Road
    TA2 6AL Taunton
    Somerset
    United KingdomBritishCompany Director103846000001
    HILL, Martin
    Parsonage Farm Parsonage Lane
    Kingston St Mary
    TA2 8HL Taunton
    Somerset
    Geschäftsführer
    Parsonage Farm Parsonage Lane
    Kingston St Mary
    TA2 8HL Taunton
    Somerset
    EnglandBritishCompany Director43510870003
    LAWTON, Simon Marcus
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    Geschäftsführer
    87-91 Newman Street
    London
    W1T 3EY
    EnglandBritishDirector68807890004
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director55231490005
    TREMBATH, Christopher Richard
    26 Mariners Drive
    Sneyd Park
    BS9 1QQ Bristol
    Geschäftsführer
    26 Mariners Drive
    Sneyd Park
    BS9 1QQ Bristol
    United KingdomBritishCompany Director77436880002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Hat NETWORK TRAINING (TAUNTON) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 14. Juni 2007
    Geliefert am 21. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 21. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture made between certain subsidiaries of tribal group PLC and the governor and company of the bank of scotland
    Erstellt am 13. Dez. 2002
    Geliefert am 24. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of each group company to the security trustee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting as Security Trustee for Itself and Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2002
    Geliefert am 23. Okt. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Apr. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Each of the Financeparties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture between the company and the south place gresham partnership 2000 (the "trustee")
    Erstellt am 22. Sept. 2000
    Geliefert am 06. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All or any monies and liabilities which shall for the time being (and whether on or at any time after demand) be due, owing or incurred in whatsoever manner by the principal to any noteholder under or in respect of any designated loan note or any other secured party whether actually or contingently and whether incurred solely, severally or jointly and whether as principal or surety and whether on account of any money advanced, bills of exchange, promissory notes, guarantees, indemnities or otherwise, including interest, discount, commission and other lawful charges or expenses with such secured party may in the course of its business charge or incur together with costs expenses and interest
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The South Place Gresham Partnership 2000
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Sept. 2000
    Geliefert am 09. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0