MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMAGNUSSEN INTERIORS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03891542
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Warth Business Centre
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MAGNUSSEN FLOORS LIMITED17. Dez. 199917. Dez. 1999
    MAGNUSSON FLOORS LIMITED09. Dez. 199909. Dez. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2020

    2 SeitenAA

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2019

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017

    2 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 49 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 33 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 52 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 53 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 55 vollständig

    2 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016

    5 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Selwyn Hotz am 02. Dez. 2016

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Harold Sydney Cohen am 02. Dez. 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 06. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015

    12 SeitenAA

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Wer sind die Geschäftsführer von MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOTZ, Selwyn
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Warth Business Centre
    Lancashire
    Sekretär
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Warth Business Centre
    Lancashire
    British29334900001
    COHEN, Harold Sydney
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Warth Business Centre
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Warth Business Centre
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director15075330002
    GOLDMAN, Charles Simon
    65 Lower Moss Lane
    Whitefield
    M45 6FA Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    65 Lower Moss Lane
    Whitefield
    M45 6FA Manchester
    Lancashire
    BritishIt Consultant67534060001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    GOLDMAN, Charles Simon
    65 Lower Moss Lane
    Whitefield
    M45 6FA Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    65 Lower Moss Lane
    Whitefield
    M45 6FA Manchester
    Lancashire
    BritishIt Consultant67534060001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Harold Sydney Cohen
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Warth Business Centre
    Lancashire
    01. Juli 2016
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Warth Business Centre
    Lancashire
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Selwyn Hotz
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Warth Business Centre
    Lancashire
    01. Juli 2016
    Warth Road
    BL9 9NB Bury
    Warth Business Centre
    Lancashire
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 27. Sept. 2005
    Geliefert am 14. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £114,000.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    10 mayfair avenue, whitefield, manchester.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation LTD
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Mai 2005
    Geliefert am 14. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £80,000.00 and all other sums due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Specific equitable charge over all estates or interest in any freehold and leasehold property and the proceeds thereof; all book and other debts,goodwill and benefit of licences; floating security over all undertaking,property,assets and rights whatsoever; 16 st anne's st,bury lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation
    Transaktionen
    • 14. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 119. Mai 2015Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 115. Mai 2021Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. März 2005
    Geliefert am 30. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £70,250.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    134 st germain street farnworth bolton greater manchester and the proceeds of sale thereof all estates or interests in any f/h and l/h property belonging to or charged to the company and/or the proceeds of sale thereof all book and other debts the goodwill and the benefit of licences floating security its undertaking and all its property assets an rights whatsoever and wheresoever present and /or future.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 30. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 219. Mai 2015Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 215. Mai 2021Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 2
    Mortgage
    Erstellt am 17. Jan. 2005
    Geliefert am 18. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £57,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    7 bransby avenue blackley.
    Berechtigte Personen
    • Mendal Fiengold
    Transaktionen
    • 18. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 20. Dez. 2004
    Geliefert am 22. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £86,000.00 and all other monies due or to become due form the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    13 palm street droylsden manchester and the proceeds of sale thereof all estates or interests in any f/h and l/h property belonging to or charged to the company and/or the proceeds of sale thereof all book and other debts the goodwill and the benefit of licences floating security its undertaking and all its property assets an rights whatsoever and wheresoever present and /or future.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation LTD
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. Dez. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £105,400.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    10 mayfair avenue whitefield manchester and/or the proceeds of sale thereof, by way of specific charge all its uncalled capital and all other f/h & l/h property..floating security all the undertaking and goodwill of the company.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation LTD
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21 rupert street, radcliffe, manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 ivy grove, kearsley, bolton. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    46 rupert street, radcliffe, manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    21 cross lane, radcliffe, manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 2004
    Geliefert am 11. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11 eager street, newton heath, manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 22. Okt. 2004
    Geliefert am 23. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14 grenville terrace ashton-under-lyne fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Sept. 2004
    Geliefert am 15. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    730 middleton road chadderton oldham fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans Limited
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Aug. 2004
    Geliefert am 20. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £185,400 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    53 wigan road standish wigan lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 20. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 06. Aug. 2004
    Geliefert am 25. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Ninety five thousand two hundred pounds and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property being 122 broadway new moston manchester by way of specific equitable charge all estates or interest in any f/h & l/h property all book debts by way of floating security its undertaking and all its property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 27. Mai 2004
    Geliefert am 07. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £64,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    13 palm street droylsden manchester M43 6WJ.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 07. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Sept. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 07. Mai 2004
    Geliefert am 14. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    25 valentine street failsworth manchester.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. März 2004
    Geliefert am 30. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £51157.50 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property 85 chapel green road hindley wigan great manchester. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 30. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. März 2004
    Geliefert am 30. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £61,320.50 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The property 16 grosvenor street cheshire and/or the proceeds of sale. All estates or interest in any f/h and l/h property, all book debts and other debts, thegoodwill and the benefit of licences. By. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Coporation LTD
    Transaktionen
    • 30. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 08. März 2004
    Geliefert am 09. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £55,150.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    174 ainsworth road radcliffe manchester.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 09. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 20. Feb. 2004
    Geliefert am 26. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £92,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    191 sale lane, tyldesley, greater manchester,.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 06. Feb. 2004
    Geliefert am 10. Feb. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £12,700.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    19 rupert street, radcliffe, manchester.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Jan. 2004
    Geliefert am 31. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £35,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    32 mossfield road, farnworth.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 16. Jan. 2004
    Geliefert am 17. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £80,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    13 frome close tyldesley greater manchester.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 17. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Dez. 2003
    Geliefert am 16. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £56,200.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    730 middleton road, chadderton.
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MAGNUSSEN INTERIORS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Kay
    407 Bury New Road
    Prestwich
    M25 1AA Manchester
    Receiver Manager
    407 Bury New Road
    Prestwich
    M25 1AA Manchester
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Kay
    407 Bury New Road
    Prestwich
    M25 1AA Manchester
    Receiver Manager
    407 Bury New Road
    Prestwich
    M25 1AA Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0