AVONSIDE ELECTRICAL SERVICES (NORTH-EAST) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AVONSIDE ELECTRICAL SERVICES (NORTH-EAST) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03892247 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AVONSIDE ELECTRICAL SERVICES (NORTH-EAST) LIMITED?
- (4531) /
- (4534) /
Wo befindet sich AVONSIDE ELECTRICAL SERVICES (NORTH-EAST) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rok Centre Guardian Road Exeter Business Park EX1 3PD Exeter Devon |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVONSIDE ELECTRICAL SERVICES (NORTH-EAST) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AVONSIDE ELECTRICAL SERVICES (NORTH-EAST) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Turnbull als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sandra Al-Kordi als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Sandra Joan Al-Kordi als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Turnbull als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Julian Patrick Turnbull als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ashley Martin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Garvis Snook als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Sellers als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Bridgewater als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Batty als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Sellers am 30. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen Bridgewater am 30. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen Michael Batty am 30. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 24 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 22 Seiten | 395 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 7 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AVONSIDE ELECTRICAL SERVICES (NORTH-EAST) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-KORDI, Sandra Joan | Sekretär | Rok Centre Guardian Road Exeter Business Park EX1 3PD Exeter Devon | 148915250001 | |||||||
| BATTY, Stephen Michael | Sekretär | 46 Nornabell Drive Kingsley Park Molescroft HU17 9GJ Beverley | British | 61237770002 | ||||||
| TURNBULL, Julian Patrick | Sekretär | The Knoll Marsh Green EX5 2ES Exeter Devon | English | 11548360002 | ||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| BATTY, Stephen Michael | Geschäftsführer | 46 Nornabell Drive Kingsley Park Molescroft HU17 9GJ Beverley | United Kingdom | British | 61237770002 | |||||
| BRIDGEWATER, Stephen | Geschäftsführer | 69 Caistor Drive TS25 2QR Hartlepool Cleveland | United Kingdom | British | 97536570001 | |||||
| DICKINSON, Ronald William | Geschäftsführer | 5 Ashworth Drive HU10 7NF Kirkella East Yorkshire | British | 25252540003 | ||||||
| MARTIN, Ashley Graham | Geschäftsführer | Spencers Farm Whelpley Hill HP5 3RP Chesham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 116805870001 | |||||
| MURRAY, Stephen | Geschäftsführer | Went View Great North Road WF8 3JP Wentbridge West Yorkshire | United Kingdom | British | 90170480001 | |||||
| PRIESTLEY, Michael | Geschäftsführer | 4 Aycliffe Gates Durham Road DL5 6GT Aycliffe Village County Durham | British | 92813000001 | ||||||
| SELLERS, Paul | Geschäftsführer | 17 Meadow Rise NE9 6GB Gateshead Tyne & Wear | United Kingdom | British | 97536180001 | |||||
| SNOOK, Garvis David | Geschäftsführer | Sloane Gardens SW1W 8EB London 13 | England | British | 70647210004 | |||||
| TURNBULL, Julian Patrick | Geschäftsführer | Rok Centre Guardian Road Exeter Business Park EX1 3PD Exeter Devon | United Kingdom | British | 148730570001 | |||||
| WILCOX, Robert Andrew | Geschäftsführer | 24 Newquay Close TS26 0XG Hartlepool Cleveland | British | 97536450001 | ||||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001440001 |
Hat AVONSIDE ELECTRICAL SERVICES (NORTH-EAST) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed | Erstellt am 30. Sept. 2009 Geliefert am 06. Okt. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. März 2009 Geliefert am 24. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any company to any pension scheme or to any pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben St james retail and business park knaresborough harrowgate t/no NYK352109 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 11. März 2009 Geliefert am 16. März 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of properties please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Feb. 2006 Geliefert am 01. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 12. Aug. 2003 Geliefert am 21. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 12. Aug. 2003 Geliefert am 19. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the charging companies to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 22. Aug. 2000 Geliefert am 29. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0