STEEL CENTRE 4 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTEEL CENTRE 4 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03898505
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STEEL CENTRE 4 LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich STEEL CENTRE 4 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kendal House
    41 Scotland Street
    S3 7BS Sheffield
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STEEL CENTRE 4 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für STEEL CENTRE 4 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    21 SeitenLIQ14

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    10 SeitenLIQ10

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2016

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2015

    18 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 93 Queen Street Sheffield S1 1WF zum Kendal House 41 Scotland Street Sheffield S3 7BS am 12. Aug. 2015

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order - replacement of liquidator
    18 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2014

    19 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:order of court appointing john russell and removing christopher michael white as liquidators of the company
    20 SeitenLIQ MISC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2013

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2012

    15 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 21. Sept. 2011

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Apr. 2011

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Okt. 2010

    12 Seiten2.24B

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 30. Juni 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Vorschlag des Verwalters

    23 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 52-54 Oswald Road Scunthorpe North Lincolnshire DN15 7PQ* am 20. Mai 2010

    2 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von STEEL CENTRE 4 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EDDY, Karen Anne
    Aspen Farm
    Holme
    DN16 3RE Scunthorpe
    South Humberside
    Sekretär
    Aspen Farm
    Holme
    DN16 3RE Scunthorpe
    South Humberside
    British151645780001
    EDDY, Delville Edwin
    25 Crosby Avenue
    DN15 8PA Scunthorpe
    North Lincolnshire
    Geschäftsführer
    25 Crosby Avenue
    DN15 8PA Scunthorpe
    North Lincolnshire
    EnglandBritish58702990001
    EDDY, Shay Vincent
    Aspen Farm
    Holme
    DN16 3RE Scunthorpe
    South Humberside
    Geschäftsführer
    Aspen Farm
    Holme
    DN16 3RE Scunthorpe
    South Humberside
    EnglandBritish67685820001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat STEEL CENTRE 4 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal assignment
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 20. Jan. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any credit balance due under the contract (the contract monies) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Floating charge (all assets)
    Erstellt am 11. Sept. 2007
    Geliefert am 13. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the 'Security Holder')
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 17. Juni 2003
    Geliefert am 18. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and singular the chattels plant machinery and things being danobat CP100.51 Semi automatic bandsaw serial no 01984455 or any part thereof.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 18. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 24. Apr. 2001
    Geliefert am 25. Apr. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("Security Holder")
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Mai 2000
    Geliefert am 20. Mai 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bay 1 & 2 plot S8 midland road scunthorpe. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Mai 2000
    Geliefert am 16. Mai 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the west of midland road scunthorpe. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Apr. 2000
    Geliefert am 26. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a bay 2 plot 58 midland road scunthorpe. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Feb. 2000
    Geliefert am 22. Feb. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)

    Hat STEEL CENTRE 4 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Apr. 2010Beginn der Verwaltung
    21. Sept. 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Michael White
    The P & A Partnership
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Praktiker
    The P & A Partnership
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Andrew Philip Wood
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Praktiker
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    2
    DatumTyp
    21. Sept. 2011Beginn der Liquidation
    01. Nov. 2017Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Philip Wood
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Praktiker
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Christopher Michael White
    The P & A Partnership
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Praktiker
    The P & A Partnership
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Gerald Maurice Krasner
    Begbies Traynor (Central) Llp 4th Floor Cathedral Buildings
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    Begbies Traynor (Central) Llp 4th Floor Cathedral Buildings
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    John Russell
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Praktiker
    The P & A Partnership 93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Ashleigh William Fletcher
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield
    Praktiker
    93 Queen Street
    S1 1WF Sheffield

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0