PALADIN GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePALADIN GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03899759
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PALADIN GROUP LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PALADIN GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    80 Cheapside
    EC2V 6EE London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PALADIN GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TOUCHSTONE ASSET MANAGEMENT LIMITED07. Apr. 200507. Apr. 2005
    INVESTIGATE LIMITED17. Feb. 200017. Feb. 2000
    OVAL (1487) LIMITED24. Dez. 199924. Dez. 1999

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PALADIN GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PALADIN GROUP LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für PALADIN GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 305 Grays Inn Road London WC1X 8QR* am 17. Apr. 2014

    1 SeitenAD01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    12 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 3,948.5
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    24 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Christopher Martin als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Christopher Robin Leslie Phillips als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Cowans als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Peter Palframan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Roxburgh Milkins Llp als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Martin Green als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2 Crescent Office Park Clarks Way Bath BA2 2AF* am 03. Dez. 2012

    1 SeitenAD01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    54 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 3,938.60
    8 SeitenSH06

    Aktienspaltung am 22. Aug. 2011

    9 SeitenSH02

    Beschlüsse

    Resolutions
    44 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Sub div 22/08/2011
    RES13
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beschlüsse

    Resolutions
    12 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Aktien

    RES09

    Wer sind die Geschäftsführer von PALADIN GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MARTIN, Christopher
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    Sekretär
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    175450390001
    COWANS, David
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritish108543490005
    HUNT, Matthew William
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2 Crescent Office Park
    Geschäftsführer
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2 Crescent Office Park
    EnglandBritish96479050001
    MIDGLEY, John Philip
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    United KingdomBritish66732700002
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Greenfield Drive
    N2 9AF London
    17
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Greenfield Drive
    N2 9AF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish46176700002
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritish47952140001
    SAUNDERS, Diana
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Sekretär
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British68743260001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Sekretär
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British47952140001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Bevollmächtigter Sekretär
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    ROXBURGH MILKINS LLP
    Roxburgh Milkins Llp Merchants
    House North Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    Sekretär
    Roxburgh Milkins Llp Merchants
    House North Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    114974370003
    ALLATT, Jonathan
    33 Partition Street
    BS1 5QJ Bristol
    Geschäftsführer
    33 Partition Street
    BS1 5QJ Bristol
    United KingdomBritish165674160002
    BARTON, Simon Edward
    5 Apsley Road
    Newbridge
    BA1 3LP Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    5 Apsley Road
    Newbridge
    BA1 3LP Bath
    Avon
    United KingdomBritish103943150001
    CHAMPION, Mark Alistair
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Geschäftsführer
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritish76512840002
    CLARK, Jonathan
    34 Church Lane
    Wingfield
    BA14 9LW Trowbridge
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    34 Church Lane
    Wingfield
    BA14 9LW Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritish103943140001
    GREEN, Martin Ian
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    EnglandBritish79471040002
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Geschäftsführer
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritish87647990001
    HUNT, Matthew William
    Roseneath
    Sharpston Freshford
    BA2 7UA Bath
    Somerset
    Geschäftsführer
    Roseneath
    Sharpston Freshford
    BA2 7UA Bath
    Somerset
    EnglandBritish96479050001
    JARRETT, Mark Stephen
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Geschäftsführer
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritish147254950001
    PALFRAMAN, Peter
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    United KingdomBritish46419220001
    TIDY, Thomas Peter
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    Geschäftsführer
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    United KingdomBritish141619610001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    Hat PALADIN GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. Juni 2011
    Geliefert am 15. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nvm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 15. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 13. Feb. 2008
    Geliefert am 20. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nvm Private Equity Limited (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 20. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 13. Feb. 2008
    Geliefert am 15. Feb. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all the rights title interest and benefit in the deposit and the deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 04. Aug. 2006
    Geliefert am 05. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured john p midgley, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number LC1006683023 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 04. Aug. 2006
    Geliefert am 05. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured neil g hollingworth, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number C11006687024 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 04. Aug. 2006
    Geliefert am 05. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured timothy saunders, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number LC1006683064 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 17. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transaktionen
    • 17. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 17. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a fixed charge all the rights title interest and benefit in the deposit and the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transaktionen
    • 17. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 11. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:john p midgley, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:LC1006683023, sum assured:£250,000.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 11. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:timothy saunders, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:LC1006683064, sum assured:£250,000.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Aug. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of life policy
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 11. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:neil g hollingworth, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:C11006684195, sum assured (exclusive of bonuses):£250,000.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 11. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge, all the rights, title interest and benefit in the deposit and in the deposit account meaning, sort code 401413, account number 82210932. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 11. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 30. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Northern Venture Managers Limited
    Transaktionen
    • 30. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Sept. 2001
    Geliefert am 06. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    750 touchstone asset management limited "a" ordinary full paid shares of £1 each and all other stocks shares bonds etc together with dividends interest or other distributions.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares
    Erstellt am 29. Juni 2000
    Geliefert am 06. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee pursuant to the instrument
    Kurze Angaben
    First fixed charge the shares and derivative assets (as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Jss Pinnacle Group Limited
    Transaktionen
    • 06. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0