PALADIN GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PALADIN GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03899759 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PALADIN GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich PALADIN GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 80 Cheapside EC2V 6EE London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PALADIN GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TOUCHSTONE ASSET MANAGEMENT LIMITED | 07. Apr. 2005 | 07. Apr. 2005 |
| INVESTIGATE LIMITED | 17. Feb. 2000 | 17. Feb. 2000 |
| OVAL (1487) LIMITED | 24. Dez. 1999 | 24. Dez. 1999 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PALADIN GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PALADIN GROUP LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PALADIN GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 305 Grays Inn Road London WC1X 8QR* am 17. Apr. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 12 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 24 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Ernennung von Christopher Martin als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Robin Leslie Phillips als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr David Cowans als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Palframan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roxburgh Milkins Llp als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Green als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2 Crescent Office Park Clarks Way Bath BA2 2AF* am 03. Dez. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 54 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Löschung von Aktien. Kapitalaufstellung am 02. Sept. 2011
| 8 Seiten | SH06 | ||||||||||||||
Aktienspaltung am 22. Aug. 2011 | 9 Seiten | SH02 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 44 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PALADIN GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Christopher | Sekretär | Gray's Inn Road WC1X 8QR London 305 England | 175450390001 | |||||||
| COWANS, David | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | England | British | 108543490005 | |||||
| HUNT, Matthew William | Geschäftsführer | Clarks Way BA2 2AF Bath 2 Crescent Office Park | England | British | 96479050001 | |||||
| MIDGLEY, John Philip | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | United Kingdom | British | 66732700002 | |||||
| PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Geschäftsführer | Greenfield Drive N2 9AF London 17 United Kingdom | England | British | 46176700002 | |||||
| SAUNDERS, Timothy, Mr. | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | England | British | 47952140001 | |||||
| SAUNDERS, Diana | Sekretär | Beckets Place Marksbury BA2 9HP Bath Avon | British | 68743260001 | ||||||
| SAUNDERS, Timothy, Mr. | Sekretär | Beckets Place Marksbury BA2 9HP Bath Avon | British | 47952140001 | ||||||
| OVALSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||
| ROXBURGH MILKINS LLP | Sekretär | Roxburgh Milkins Llp Merchants House North Wapping Road BS1 4RW Bristol | 114974370003 | |||||||
| ALLATT, Jonathan | Geschäftsführer | 33 Partition Street BS1 5QJ Bristol | United Kingdom | British | 165674160002 | |||||
| BARTON, Simon Edward | Geschäftsführer | 5 Apsley Road Newbridge BA1 3LP Bath Avon | United Kingdom | British | 103943150001 | |||||
| CHAMPION, Mark Alistair | Geschäftsführer | Crescent Office Park Clarks Way BA2 2AF Bath 2 | England | British | 76512840002 | |||||
| CLARK, Jonathan | Geschäftsführer | 34 Church Lane Wingfield BA14 9LW Trowbridge Wiltshire | United Kingdom | British | 103943140001 | |||||
| GREEN, Martin Ian | Geschäftsführer | Grays Inn Road WC1X 8QR London 305 United Kingdom | England | British | 79471040002 | |||||
| HOLLINGWORTH, Neil Gregory | Geschäftsführer | Bridge House Addington MK18 2JX Winslow Bucks | United Kingdom | British | 87647990001 | |||||
| HUNT, Matthew William | Geschäftsführer | Roseneath Sharpston Freshford BA2 7UA Bath Somerset | England | British | 96479050001 | |||||
| JARRETT, Mark Stephen | Geschäftsführer | Crescent Office Park Clarks Way BA2 2AF Bath 2 | England | British | 147254950001 | |||||
| PALFRAMAN, Peter | Geschäftsführer | Grays Inn Road WC1X 8QR London 305 United Kingdom | United Kingdom | British | 46419220001 | |||||
| TIDY, Thomas Peter | Geschäftsführer | 24 Handel Mansions 94 Wyatt Drive SW13 8AH London | United Kingdom | British | 141619610001 | |||||
| OVAL NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002560001 | |||||||
| OVALSEC LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 |
Hat PALADIN GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 10. Juni 2011 Geliefert am 15. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Feb. 2008 Geliefert am 20. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 13. Feb. 2008 Geliefert am 15. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all the rights title interest and benefit in the deposit and the deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 04. Aug. 2006 Geliefert am 05. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured john p midgley, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number LC1006683023 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 04. Aug. 2006 Geliefert am 05. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured neil g hollingworth, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number C11006687024 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 04. Aug. 2006 Geliefert am 05. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured timothy saunders, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number LC1006683064 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 17. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 17. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of a fixed charge all the rights title interest and benefit in the deposit and the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:john p midgley, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:LC1006683023, sum assured:£250,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:timothy saunders, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:LC1006683064, sum assured:£250,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of life policy | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:neil g hollingworth, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:C11006684195, sum assured (exclusive of bonuses):£250,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge, all the rights, title interest and benefit in the deposit and in the deposit account meaning, sort code 401413, account number 82210932. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 11. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juni 2006 Geliefert am 30. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 25. Sept. 2001 Geliefert am 06. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 750 touchstone asset management limited "a" ordinary full paid shares of £1 each and all other stocks shares bonds etc together with dividends interest or other distributions. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 29. Juni 2000 Geliefert am 06. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee pursuant to the instrument | |
Kurze Angaben First fixed charge the shares and derivative assets (as defined).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0