35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03902892 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FORTUNEHURST LIMITED | 06. Jan. 2000 | 06. Jan. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 24 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip John Martin als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip John Martin als Sekretär am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von British Land Company Secretarial Limited als Sekretär am 31. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Charles John Middleton als Direktor am 13. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Jonathan Charles Mcnuff als Direktor am 13. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip John Martin am 02. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Andrew David Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
| GROSE, Benjamin Toby | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 146546000001 | |||||||||
| MCNUFF, Jonathan Charles | Geschäftsführer | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 205624050001 | |||||||||
| MIDDLETON, Charles John | Geschäftsführer | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | 79841030002 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Sekretär | Runwick Hill Runwick Lane GU10 5EE Farnham Surrey | British | 35118050001 | ||||||||||
| WILSON, Michael Anthony | Sekretär | 4 Alleyn Road SE21 8AL London | British | 68971270001 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
| BERESFORD, Valentine Tristram | Geschäftsführer | 3 Smith Terrace SW3 4DL London | England | British | 40766290003 | |||||||||
| CHARLTON, Peter John | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 17 Kirkdale Road AL5 2PT Harpenden Hertfordshire | British | 900005610001 | ||||||||||
| CLUTTON, Rodney | Geschäftsführer | Grange Farm CV23 8DJ Grandborough Warwickshire | British | 4388360001 | ||||||||||
| DOYLE, Eugene Francis | Geschäftsführer | 2 Gombards AL3 5NW St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | Irish | 73961570001 | |||||||||
| JONES, Andrew Marc | Geschäftsführer | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||||||
| MARTIN, Philip John | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 35118050001 | |||||||||
| MCGANN, Martin Francis | Geschäftsführer | 10 Westcombe Park Road SE3 7RB Blackheath London | British | 109383240001 | ||||||||||
| NETTLETON, John Dering | Geschäftsführer | Newington House OX10 7AG Warborough Oxfordshire | England | English | 1866530002 | |||||||||
| PRICE, Humphrey James Montgomery | Geschäftsführer | Deaks Deaks Lane RH17 5JA Cuckfield West Sussex | Uk | British | 14448630001 | |||||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
| SMITH, Andrew David | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 108214880002 | |||||||||
| STIRLING, Mark Andrew | Geschäftsführer | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | 106882210001 | |||||||||
| TYLER, Michael Peters | Geschäftsführer | Haydon Park Road SW19 8JH London 99 | British | 108051840001 | ||||||||||
| VAUGHAN, Patrick Lionel | Geschäftsführer | June Farm Trumpet Hill Road RH2 8QY Reigate Surrey | United Kingdom | British | 73972350001 | |||||||||
| WATES, Paul Christopher Ronald | Geschäftsführer | Bellasis House Headley Heath Approach Mickleham RH5 6DH Dorking Surrey | England | British | 2119440001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basinghall Street Unit Trust | 06. Jan. 2017 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 24. März 2005 Geliefert am 07. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a basinghall house 35 basinghall street london. Its interest in all investments, all plant and machinery, all book debts and other debts, any benefit in any pension fund, its goodwill and benefit of any authorisation. Floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 05. Juli 2004 Geliefert am 14. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement between each chargor (as defined) and the agent | Erstellt am 02. Juli 2001 Geliefert am 16. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Freehold land k/a city point (formerly k/a britannic tower) moor lane london EC2 t/n NGL745546 for further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 18. Apr. 2001 Geliefert am 03. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the chargor to any finance party under each finance document to which the chargor is a party except for any obligation which if it were so included would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Nov. 2000 Geliefert am 08. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from wates city of london properties PLC (borrower) to the chargee under the finance documents (as defined therein) | |
Kurze Angaben The f/h property k/a basinghall house, basinghall street comprising 31-36 basinghall street, 1 & 2 basinghall avenue and guildhall chambers london t/n LN191861. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Okt. 2000 Geliefert am 25. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance party (or any of them) under each of the finance documents to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben F/H property k/a basinghall house basinghall street comprising 31-36 basinghall street, 1 & 2 basinghall avenue and guildhall chambers london EC2 t/n LN191861. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. März 2000 Geliefert am 30. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them under each of the finance documents (all defined therein) | |
Kurze Angaben F/H property k/a basinghall house, basinghall street comprising 31-36 basinghall street, 1&2 basinghall avenue and guildhall chambers, london EC2. T/no. LN191861. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0