CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED

CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03910381
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED?

    • (2452) /

    Wo befindet sich CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. März 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    4 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Nov. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    4 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL am 22. Dez. 2009

    1 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Nov. 2009

    12 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    17 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2008

    25 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht

    20 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    44 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    19 Seiten395

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    THIRLWELL, Wendy Denise
    Manvers 15 Golwg Yr Afon
    Llangennech
    SA14 8SX Llanelli
    Dyfed
    Sekretär
    Manvers 15 Golwg Yr Afon
    Llangennech
    SA14 8SX Llanelli
    Dyfed
    BritishExecutive Pa114068060001
    MELDRUM, Stuart
    32 Chargot Road
    CF5 1EW Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    32 Chargot Road
    CF5 1EW Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritishChief Executive Officer102237980001
    OREN, Ran
    28 Wolsey Way
    CB1 3JQ Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    28 Wolsey Way
    CB1 3JQ Cambridge
    Cambridgeshire
    United KingdomGermanChief Financial Officer113744540001
    TOLAN, Bobby Jay
    11203 Gregory Lane
    75035 Frisco
    Texas
    United States Of America
    Geschäftsführer
    11203 Gregory Lane
    75035 Frisco
    Texas
    United States Of America
    AmericanExecutive Chairman90919790004
    DONNELLY, John Michael
    Timbers Ridge
    Franksfield
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    Sekretär
    Timbers Ridge
    Franksfield
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    BritishDirector153980720001
    HENRIKSEN, Alison Jane
    428 Upper Richmond Road West
    TW10 5DY Richmond
    Surrey
    Sekretär
    428 Upper Richmond Road West
    TW10 5DY Richmond
    Surrey
    BritishC F O102224500002
    LASHBROOKE, Andrew Michael
    2 Lavender Gate
    Steels Lane
    KT22 0RE Oxshott
    Surrey
    Sekretär
    2 Lavender Gate
    Steels Lane
    KT22 0RE Oxshott
    Surrey
    South African81345910001
    NICHOLLS, Duncan
    Tanglin Manor Road
    Penn
    HP10 8HY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Tanglin Manor Road
    Penn
    HP10 8HY High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant17828040001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DONNELLY, John Michael
    Timbers Ridge
    Franksfield
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    Geschäftsführer
    Timbers Ridge
    Franksfield
    GU5 9SR Peaslake
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant153980720001
    HENRIKSEN, Alison Jane
    428 Upper Richmond Road West
    TW10 5DY Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    428 Upper Richmond Road West
    TW10 5DY Richmond
    Surrey
    BritishFinance Director102224500002
    LASHBROOKE, Andrew Michael
    2 Lavender Gate
    Steels Lane
    KT22 0RE Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    2 Lavender Gate
    Steels Lane
    KT22 0RE Oxshott
    Surrey
    South AfricanDirector81345910001
    LESCH, Anthony
    111 St Pancras Road
    PO19 4LH Chichester
    West Sussex
    Geschäftsführer
    111 St Pancras Road
    PO19 4LH Chichester
    West Sussex
    South AfricanBusiness Development Director68564160002
    MCGEE, Martin
    Two Hoots Barn
    Knutsford Road, Mobberley
    WA16 7BG Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Two Hoots Barn
    Knutsford Road, Mobberley
    WA16 7BG Knutsford
    Cheshire
    BritishTechnical Director66130950001
    MCNALLY, Ian Richard Armstrong
    Woodcote House
    Lodge Green Burton Park
    GU28 0LH Petworth
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Woodcote House
    Lodge Green Burton Park
    GU28 0LH Petworth
    West Sussex
    EnglandBritishDirector115019860001
    NICHOLLS, Duncan
    Tanglin Manor Road
    Penn
    HP10 8HY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Tanglin Manor Road
    Penn
    HP10 8HY High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant17828040001
    TASHJIAN, David
    24 The Cottrells
    BN16 4AF Angmering
    West Sussex
    Geschäftsführer
    24 The Cottrells
    BN16 4AF Angmering
    West Sussex
    AmericanDirector100002830001
    TEN HOPE, Michael Frits
    Hilliards House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    Hilliards House
    Amlets Lane
    GU6 7DH Cranleigh
    Surrey
    South AfricanCompany Director77298500002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of variation and charge
    Erstellt am 18. Juni 2007
    Geliefert am 28. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each and every other security obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the littlehampton equipment being york YCAL0347SBXA chiller, netsch 602 de-aerator s/n 510248/01 and omas capping machine for details of maesteg equipment and other equipment please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment of the benefit of certain insurance policies
    Erstellt am 18. Juni 2007
    Geliefert am 28. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each and every other security obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Right title and interest in and to the policies and the replacement policies. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 25. Mai 2007
    Geliefert am 01. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All plant and machinery vehicles all other equipment and all spare parts being the charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 14. Feb. 2007
    Geliefert am 21. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Underlease relating to factory and warehouse hawthorn road wick littlehampton west sussex. Underlease relating to factory unit 5 watermead business park littlehampton west sussex. Underlease relatingto unit 8 watermead business park worthing lane littlehampton west sussex (for details of further properties charged ple. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Assembly for Wales
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 30. Okt. 2006
    Geliefert am 08. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all the plant and machinery and all vehicles of the company listed in schedule 1 to the chattel mortgage; all other equipment of the company and all spare parts, replacements, modifications and addition for or to the same and the full benefit of all insurances, warranties and maintenance contracts in relation thereto. (The "charged assets"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 21. Feb. 2006
    Geliefert am 28. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and all monies due or to become due from each and every other security obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Underlease relating to factory and warehouse hawthorn road wick littlehampton west sussex, underlease relating to factory unit 5 watermead business park littlehampton west sussex, underlease relating to unit 8 watermead business park worthing lane littlehampton west sussex. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Apr. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 09. Feb. 2006
    Geliefert am 09. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1 omso novax m uv 4 colour screen print inline machine s/no 1301522-95(1995), 1 omso novax m uv 4 colour screen print inline machine s/no 1301329-94 (1994), 1 medway novopac package shrink wrapper for details of further plant & machinery charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 14. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from cosi (bahamas) limited or any company to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property land on the east side of oakwood drive and on the west side of ewenny road, maesteg, bridgend, mid glamorgan. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Industrial Development Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 14. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 2001
    Geliefert am 02. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities due, owing or incurred to any secured party by any charging company or any other obligor (as defined therein) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deposit agreement to secure liabilities of a third party
    Erstellt am 30. Juli 2001
    Geliefert am 08. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from 2147TH single member shelf investment company limited (to be known as cw cosmetics limited) to the chargee under or in relation to a £3,500,000 overdraft facility letter issued by the bank
    Kurze Angaben
    First fixed charge all such rights to the repayment of the deposit as the depositor may have under the terms upon which the deposit was made and the previsions hereinbefore contained (or otherwise howsoever) in and to the account(s) with the bank at it's littlehampton branch (sort code 30-05-09) in the name of creative outsourcing solutions international limited designated "lloyds tsb re;-creative outsourcing solutions international limited" (or similar) denominated in sterling now numbered 01161971 and any account(s) replacing thereto.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Feb. 2000
    Geliefert am 04. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rmb International (Dublin) Limited
    Transaktionen
    • 04. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. März 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CREATIVE OUTSOURCING SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2007Beginn der Verwaltung
    07. Nov. 2008Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathan Scott Pope
    2 Cornwall Street
    Birmingahm
    B3 2DL
    Praktiker
    2 Cornwall Street
    Birmingahm
    B3 2DL
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Myles Anthony Halley
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    2
    DatumTyp
    07. Nov. 2008Beginn der Liquidation
    06. Okt. 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Myles Anthony Halley
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Jonathan Scott Pope
    Kpmg
    Marlborough House
    Fitzalan Court
    Fitzalan Road Cardiff Cf24 Ote
    Praktiker
    Kpmg
    Marlborough House
    Fitzalan Court
    Fitzalan Road Cardiff Cf24 Ote
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Richard James Philpott
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0