OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03914814 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Entwicklung von Geschäfts- und Haushaltssoftware (62012) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CLARITY COMMERCE SOLUTIONS LIMITED | 02. Mai 2012 | 02. Mai 2012 |
| CLARITY COMMERCE SOLUTIONS PLC | 03. Juli 2000 | 03. Juli 2000 |
| CLARITY GROUP 2000 PLC | 24. Jan. 2000 | 24. Jan. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 19 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Sovereign House C/O M-Hance Limited Stockport Road Cheadle SK8 2EA zum Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU am 04. Jan. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 10 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Victoria Anne Chandler als Sekretär am 07. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB England zum Sovereign House C/O M-Hance Limited Stockport Road Cheadle SK8 2EA am 26. Aug. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite 29, 80 Churchill Square Kings Hill West Malling ME19 4YU England zum The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB am 05. Jan. 2022 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan John Moody als Direktor am 17. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mel David Taylor als Geschäftsführer am 16. Apr. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB England zum The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf The Square Basing View Basingstoke RG21 4EB geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 200 Cedarwood, Crockford Lane Chineham Business Park Basingstoke RG24 8WD England zum Suite 29, 80 Churchill Square Kings Hill West Malling ME19 4YU am 15. März 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 29 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 039148140006, erstellt am 30. Sept. 2020 | 30 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRATTON, Nicholas Julian | Geschäftsführer | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | United Kingdom | British | 248433320001 | |||||
| MOODY, Alan John | Geschäftsführer | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | England | British | 245409680001 | |||||
| ARNOLD, Richard Stewart | Sekretär | Palmer Road SP2 7LX Salisbury 5 Wiltshire | British | 60617500004 | ||||||
| CHANDLER, Victoria Anne | Sekretär | C/O M-Hance Limited Stockport Road SK8 2EA Cheadle Sovereign House | 212445670001 | |||||||
| MCDERMOTT, Thomas Paul | Sekretär | Newitt Place SO16 7FA Southampton 33 Hampshire | British | 134045580002 | ||||||
| MITCHELL, Christopher John | Sekretär | 53 Stoke Lane Westbury On Trym BS9 3DW Bristol | British | 19750010001 | ||||||
| SADLER, Stephen | Sekretär | Hatch Warren Lane Hatch Warren RG22 4RA Basingstoke Paterson House Hatch Warren Farm Hampshire | 158469870001 | |||||||
| WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion | Sekretär | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | 165681510001 | |||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| ARCHER, Oliver Carl | Geschäftsführer | Cedarwood, Crockford Lane Chineham Business Park RG24 8WD Basingstoke 200 England | England | British | 150218430001 | |||||
| ASPLIN, Robert Alexander | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | United Kingdom | British | 149870270004 | |||||
| ASPLIN, Robert Alexander | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | Uk | British | 149870270001 | |||||
| BELLAMY, Stephen Gerard | Geschäftsführer | 220 Forest Road TN2 5HS Tunbridge Wells Kent | England | New Zealander | 40573970001 | |||||
| BENNETT, David | Geschäftsführer | Hatch Warren Lane Hatch Warren RG22 4RA Basingstoke Paterson House Hatch Warren Farm Hampshire | England | British | 150734470001 | |||||
| BITTLESTON, Timothy Steven | Geschäftsführer | Stoneleigh Beyne Road SO22 4JW Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 74438980002 | |||||
| BOUZAC, Thierry Georges | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | French | 87674390003 | |||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | 201347710001 | |||||
| CHANDLER, Colin Michael, Sir | Geschäftsführer | Wray Farm 90 Raglan Road RH2 0ET Reigate Surrey | United Kingdom | British | 14321370002 | |||||
| FORD, Christopher Mark | Geschäftsführer | 69 Sillswood MK46 5PN Olney Buckinghamshire | England | British | 116469010001 | |||||
| GIBBON, David Keith Christopher | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 49959390002 | |||||
| HENRY, William Patrick | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | American | 159943040001 | |||||
| HOULDSWORTH, Anthony | Geschäftsführer | 80 Brownhill Road Chandlers Ford SO53 2EJ Eastleigh Hampshire | England | British | 15821890002 | |||||
| KRAUS, Bonnie Phik Shan | Geschäftsführer | Cedarwood, Crockford Lane Chineham Business Park RG24 8WD Basingstoke 200 England | United Kingdom | British | 159101620002 | |||||
| MORTON, Arthur Leonard Robert | Geschäftsführer | Wappenbury Hall Wappenbury CV33 9DW Leamington Spa Warwickshire | British | 1827570001 | ||||||
| NEWTON, Benjamin James | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | United Kingdom | British | 183501540001 | |||||
| O'CONNELL, John Anthony | Geschäftsführer | Sheepcote Grange Wooburn Common Road Wooburn Common HP10 0JS High Wycombe Buckinghamshire | United Kingdom | Irish | 102893540001 | |||||
| O'HARA, John William | Geschäftsführer | 124 Bawden Road Rd2 Albany Auckland 0792 New Zealand | New Zealand | New Zealand | 152604340001 | |||||
| PILLING, Simon Christopher | Geschäftsführer | Cedarwood, Crockford Lane Chineham Business Park RG24 8WD Basingstoke 200 England | United Kingdom | British | 203009530001 | |||||
| SADLER, Stephen Paul | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 90689640003 | |||||
| SANDERS, Nicholas Ian Burgess | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 83283880002 | |||||
| SHEARMON, David Frederick James | Geschäftsführer | 18 Devonshire Road SP1 3NW Salisbury Wiltshire | British | 28122660002 | ||||||
| SKINNER, Andrew Merrick | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | 189498050001 | |||||
| SMITH, Kenneth Ronald | Geschäftsführer | Telconia Close Headley Down GU35 8ED Bordon 7 Hampshire | United Kingdom | British | 34793900002 | |||||
| TAYLOR, Mel David | Geschäftsführer | Churchill Square Kings Hill ME19 4YU West Malling Suite 29, 80 England | England | English | 203242420001 | |||||
| TEE, Fiona | Geschäftsführer | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 66385440005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnico Group Limited | 06. Apr. 2016 | Le Marchant Street GY1 4HY St Peter Port Heritage Hall Guernsey | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Jonathan Paul Moulton | 06. Apr. 2016 | Buckingham Street WC2N 6DF London Better Capital Ltd, 10 England | Nein | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: Guernsey | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 30. Sept. 2020 Geliefert am 30. Sept. 2020 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 08. Jan. 2015 Geliefert am 12. Jan. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The company charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by paragraph (a) above;. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets); and. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by paragraph (c) above. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Sept. 2012 Geliefert am 25. Sept. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 16. Okt. 2001 Geliefert am 16. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All sums (denominated in whatever currency) together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit ("the deposit") of the account (denominated in whatever currency) of the company with bos at birmingham which is now numbered 00185304 as the same may be replaced, redesignated, renumbered or rearranged from time to time and all the present and future rights, titles and benefit of the company whatsoever in the deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit | Erstellt am 16. Okt. 2001 Geliefert am 16. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All sums (denominated in whatever currency) together with all interest and other amounts accruing on such sums for the time being and from time to time standing to the credit ("the deposit") of the account (denominated in whatever currency) of the company with bos at birmingham which is now numbered 00185400 as the same may be replaced, redesignated, renumbered or rearranged from time to time and all the present and future rights, titles and benefit of the company whatsoever in the deposit. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Okt. 2001 Geliefert am 16. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat OMNICO GROUP HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0