SNTL REALISATIONS 2011 LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSNTL REALISATIONS 2011 LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03924648
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    • (2852) /
    • (7487) /

    Wo befindet sich SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp PO BOX 695 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SANTIA LTD01. Dez. 201001. Dez. 2010
    CONNAUGHT COMPLIANCE LIMITED29. Jan. 200729. Jan. 2007
    CONNAUGHT R B S LTD21. Aug. 200221. Aug. 2002
    CONNAUGHT PROPERTY SERVICES (RBS) LTD24. Dez. 200124. Dez. 2001
    RETAIL BUILDING SERVICES LIMITED14. Feb. 200014. Feb. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Aug. 2013

    34 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 09. Aug. 2013

    34 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Mai 2013

    36 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    33 Seiten2.39B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Nov. 2012

    40 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Mai 2012

    37 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Dez. 2011

    36 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Aug. 2011

    43 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    11 Seiten2.16B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    56 Seiten2.17B

    Beendigung der Bestellung von Ian Carlisle als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Santia House Caerphilly Business Park Caerphilly Mid Glamorgan CF83 3GG Wales am 23. Feb. 2011

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Verschiedenes

    Certificate of fact - name correction from sntl realisations LTD to sntl realisations 2011 LTD
    1 SeitenMISC

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed santia LTD\certificate issued on 09/02/11
    4 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 31. Jan. 2011

    RES15
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    10. Feb. 2011Other CHANGED ITS NAME ON 9TH FEBRUARY 2011 LTD TO SNTL REALISATIONS 2011 LTD AND NOT THE NAME SNTL REALISATIONS LTD AS INCORRECTLY SHOWN ON THE FACE OF THE CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME ISSUED ON THAT DATE.

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Beendigung der Bestellung von Julia Cavanagh als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Julia Cavanagh als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Sekretär
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British146809540001
    LUXON, Gail Corrine
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    Sekretär
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    British46661570001
    MATTHEWS, Samantha Louise
    3 Boundary Way
    BA6 9PJ Glastonbury
    Somerset
    Sekretär
    3 Boundary Way
    BA6 9PJ Glastonbury
    Somerset
    British68772020001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Sekretär
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    British64426280002
    PHILLIPS, Jackey
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Sekretär
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British104367080003
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Sekretär
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    British99914770001
    WALSH, Robert Daniel
    Vine Cottage
    76 Carlingcott
    BA2 8AP Peasedown St John
    Bath
    Sekretär
    Vine Cottage
    76 Carlingcott
    BA2 8AP Peasedown St John
    Bath
    British60752980001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    ALDEN, Jeffrey Stephen Denton
    4 Ryeworth Road
    Charlton Kings
    GL52 6LH Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    4 Ryeworth Road
    Charlton Kings
    GL52 6LH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish100615010001
    BRAY, Iain Richard
    Banbury Road
    CV37 7HX Stratford-Upon-Avon
    198
    Warwickshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Banbury Road
    CV37 7HX Stratford-Upon-Avon
    198
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154064760001
    BROWN, Paul John
    21 Beech Close
    Meadow Park
    EX15 2SD Willand
    Devon
    Geschäftsführer
    21 Beech Close
    Meadow Park
    EX15 2SD Willand
    Devon
    EnglandBritish183591260001
    CARLISLE, Ian
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Kpmg Llp PO BOX 695 8
    Geschäftsführer
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Kpmg Llp PO BOX 695 8
    EnglandBritish146715900001
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    United Kingdom
    United KingdomBritish140133020001
    DARBY SHIRE, Ian
    High Barn
    BD23 3PU Flasby
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    High Barn
    BD23 3PU Flasby
    North Yorkshire
    British101620840001
    DAVIES, Mark Dingad
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish203044250004
    HILL, Stephen Ronald
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    Geschäftsführer
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    United KingdomBritish115233060001
    LUXON, Gail Corrine
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    Geschäftsführer
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    United KingdomBritish46661570001
    LUXON, Michael John
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    Geschäftsführer
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    United KingdomBritish34313080001
    PROWSE, John
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    EnglandBritish96786510001
    QUINN, Derek Anthony
    26 Effingham Road
    St Andrews
    BS6 5BJ Bristol
    Geschäftsführer
    26 Effingham Road
    St Andrews
    BS6 5BJ Bristol
    British72848250001
    TINCKNELL, Mark William
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    Geschäftsführer
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    EnglandBritish4088810003
    WELLS, David Francis
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    United KingdomBritish104366980002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Hat SNTL REALISATIONS 2011 LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage of shares
    Erstellt am 06. Aug. 2009
    Geliefert am 25. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 06. Aug. 2009
    Geliefert am 25. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Security agreement
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 21. Mai 2009
    Geliefert am 28. Mai 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first equitable mortgage all the shares and by way of a first fixed charge its interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 28. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    A mortgage of shares agreement
    Erstellt am 09. Nov. 2007
    Geliefert am 28. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first equitable mortgage all the shares and by way of a first fixed charge its interest in the shares (including all related rights). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    A security agreement
    Erstellt am 17. Aug. 2007
    Geliefert am 31. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Dez. 2006
    Geliefert am 16. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 2004
    Geliefert am 20. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 29. Juni 2001
    Geliefert am 04. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Juli 2000
    Geliefert am 14. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Juni 2000
    Geliefert am 29. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SNTL REALISATIONS 2011 LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Feb. 2011Beginn der Verwaltung
    09. Aug. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Heis
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Praktiker
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0