SDG IRELAND LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SDG IRELAND LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03930266 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SDG IRELAND LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich SDG IRELAND LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 82 St John Street EC1M 4JN London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SDG IRELAND LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SCARBOROUGH DEVELOPMENT IRELAND LIMITED | 23. Okt. 2002 | 23. Okt. 2002 |
| TEESLAND IRELAND LIMITED | 05. Apr. 2000 | 05. Apr. 2000 |
| MUTANDERIS (359) LIMITED | 16. Feb. 2000 | 16. Feb. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SDG IRELAND LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Feb. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SDG IRELAND LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Okt. 2020 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Okt. 2019 | 11 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Okt. 2018 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ zum 82 st John Street London EC1M 4JN am 08. Aug. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 6 Seiten | 600 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in freiwilliger Mitgliederliquidation | 2 Seiten | REST-MVL | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 9 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 039302660015 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 039302660014 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 039302660013 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Feb. 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Charles Mccabe am 30. Juni 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Simon Charles Mccabe am 06. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 039302660015, erstellt am 01. Aug. 2014 | 57 Seiten | MR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 7 Seiten | MA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SDG IRELAND LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPLANADE SCRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 125618730001 | ||||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire | England | British | 154915110001 | |||||||||
| ESPLANADE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire England |
| 123430390001 | ||||||||||
| BROOK, Susan Margaret | Sekretär | 16 Bradley Lane Rufforth YO23 3QJ York North Yorkshire | British | 72328070001 | ||||||||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Sekretär | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | British | 1267050001 | ||||||||||
| MCCABE, Sandra | Sekretär | 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough The White House North Yorkshire | British | 920260005 | ||||||||||
| BART SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | C/O Laytons Carmelite 5th Floor 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0LS London | 900005780001 | |||||||||||
| TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 93 George Street EH2 3ES Edinburgh | 90707230001 | |||||||||||
| FINLAY, Mark James | Geschäftsführer | 4 Croft Rise Croft Road BT18 0QG Holywood Belfast | Northern Ireland | British | 115223630001 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| MCCABE, Simon Charles | Geschäftsführer | 5 Rothesay Mews EH3 7SG Edinburgh | British | 103888320001 | ||||||||||
| MURRAY, Alan Adams | Geschäftsführer | 3 Otterburn Park EH14 1JX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 559270001 | |||||||||
| TANDY, Didier Michel | Geschäftsführer | 9 Warrington Crescent W9 1ED London | England | British | 69909950001 | |||||||||
| BART MANAGEMENT LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | C/O Laytons Carmelite 5th Floor 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0LS London | 900005790001 | |||||||||||
| EUROPA DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Europa House 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough North Yorkshire | 102560510001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SDG IRELAND LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarborough Property Developments Limited | 06. Apr. 2016 | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SDG IRELAND LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 01. Aug. 2014 Geliefert am 21. Aug. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 14. Nov. 2013 Geliefert am 21. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Micro focus house 2-14 east bridge street belfast t/no.AN154698 county antrim. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 14. Nov. 2013 Geliefert am 21. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Micro focus house 2-14 east bridge street belfast folio AN154698 county antrim. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2011 Geliefert am 26. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each guarantor and the company to the refinancing fee beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floral buildings 2-14 east bridge street belfast t/no AN154698 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2011 Geliefert am 26. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Floral buildings 2-14 east bridge street belfast t/n AN154698, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2011 Geliefert am 26. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each guarantor and the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 2011 Geliefert am 26. Mai 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. März 2009 Geliefert am 03. Apr. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Apr. 2006 Geliefert am 12. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from sdg property holdings limited (formerly teesloch limited) and the other companies named as borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The piece of land in verner street belfast, all that property comprised in a conveyance dated 12TH december 2000 between james murdoch and scarborough development limited being that portion of the premises comprised in the grant situated in verner street belfast, and 2/14 east bridge street belfast, 15 verner street belfast and 16 and 18 market street belfast. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Juli 2001 Geliefert am 21. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises at and known as nos 20/24 cromac st,belfast and premises at and known as nos 10/18 cromac street and 33/37 market st,belfast with all machinery utensils and things thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over all book debts | Erstellt am 30. Jan. 2001 Geliefert am 20. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book and other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 30. Jan. 2001 Geliefert am 20. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Solicitors'undertaking | Erstellt am 19. Dez. 2000 Geliefert am 09. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 10/18 cromac street belfast and 33/37 market street belfast. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Solicitor's undertaking | Erstellt am 30. Nov. 2000 Geliefert am 13. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a 20/24 cromac street/cromac square belfast northern ireland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 12. Mai 2000 Geliefert am 22. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floral buildings 2/14 east bridge street 15 verner street and 16/18 market street belfast together with all buildings fixtures fixed plant and machinery book and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SDG IRELAND LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0