MALMAISON (READING) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MALMAISON (READING) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03932085 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MALMAISON (READING) LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich MALMAISON (READING) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Appold Street EC2A 2HB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MALMAISON (READING) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MWB FRIAR STREET TWO LIMITED | 24. Mai 2000 | 24. Mai 2000 |
MWB CANNON CENTRE LEASE LIMITED | 12. Mai 2000 | 12. Mai 2000 |
FINLAW 207 LIMITED | 23. Feb. 2000 | 23. Feb. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MALMAISON (READING) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MALMAISON (READING) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2016 bis 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 15 Appold Street London EC2A 2HB verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1FE verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom One Fleet Place London EC4M 7WS zum 15 Appold Street London EC2A 2HB am 22. Juni 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Wfw Legal Services Limited als Sekretär am 17. Juni 2015 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 039320850008 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Reginald Davis als Geschäftsführer am 17. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift One Fleet Place London EC4M 7WS verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 039320850008 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 11 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 039320850008 | 94 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Roberts am 30. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MALMAISON (READING) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFW LEGAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Appold Street EC2A 2HB London 15 England |
| 18093320001 | ||||||||||
ROBERTS, Paul | Geschäftsführer | Appold Street EC2A 2HB London 15 England | United Kingdom | British | Finance Director | 168184220001 | ||||||||
ROBSON, Gail | Sekretär | Great Portland Street W1W 5LS London 179 England | British | Accountant | 100895090001 | |||||||||
FILEX SERVICES LIMITED | Sekretär | 179 Great Portland Street W1W 5LS London | 3620420001 | |||||||||||
BALFOUR-LYNN, Richard Gary | Geschäftsführer | Connaught Square W2 2HG London 6 | United Kingdom | British | Company Director | 34251500001 | ||||||||
BIBRING, Michael Albert | Geschäftsführer | Conifers Hive Road WD23 1JG Bushey Heath Hertfordshire | England | British | Solicitor | 9320160002 | ||||||||
BLURTON, Andrew Francis | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5LS London 179 England | England | British | Company Director | 53724380001 | ||||||||
COOK, Robert Barclay | Geschäftsführer | Longhoughton Road Lesbury NE66 3AT Alnwick Dukes Ryde Northumberland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 136758210001 | ||||||||
DAVIS, Gary Reginald | Geschäftsführer | EC4M 7WS London One Fleet Place England | England | British | Ceo | 167510270002 | ||||||||
ELLIOT, Colin David | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5LS London 179 England | England | British | Finance Director | 154267590001 | ||||||||
HARRISON, John William | Geschäftsführer | 97 Clifton Hill NW8 0JR London | United Kingdom | British | Director | 69263980002 | ||||||||
NISBETT, Paul Sandle | Geschäftsführer | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | Director | 132613500001 | ||||||||
SHASHOU, Joseph Saleem | Geschäftsführer | 28 Elm Tree Road NW8 9JT London | United Kingdom | Brazilian | Company Director | 51723030002 | ||||||||
SINGH, Jagtar | Geschäftsführer | West Garden Place Kendal Street W2 2AQ London 1 England | United Kingdom | British | Director | 121710890001 | ||||||||
FILEX NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 179 Great Portland Street W1W 5LS London | 67847560001 |
Hat MALMAISON (READING) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 01. Apr. 2014 Geliefert am 11. Apr. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The f/h and l/h land under t/no's BK149209 (f/h) and BK128232 (l/h) and k/a the malmaison hotel station road reading. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Feb. 2008 Geliefert am 14. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 01. Juni 2006 Geliefert am 14. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each of the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all its right,title benefit and interest (present and future) in the construction documentation. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Okt. 2005 Geliefert am 16. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Great western house station road reading t/nos bk 149209 and bk 128232 the rental sums the proceeds of each policy of insurance all buildings structures plant and machinery the goodwill floating charge all unattached plant machinery chattels and goods. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Okt. 2005 Geliefert am 16. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to each of the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Juni 2003 Geliefert am 16. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor or, any of them to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Great western house station road reading part t/no BK149209, part t/no BK128232 and part t/no BK379001. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 27. Mai 2003 Geliefert am 28. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the property and its interest in all existing and future fittings plant equipment machinery tools furniture and other tangibel moveable property situate on at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 27. Juni 2000 Geliefert am 29. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies owed to the beneficiaries (as defined) under or in connection with the finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0