INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED

INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03934724
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED?

    • Großhandel mit chemischen Produkten (46750) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Interpath Ltd
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INEOS CHLOR SALES INTERNATIONAL LIMITED19. Feb. 200119. Feb. 2001
    RUNCORN CHEMICALS LTD28. Feb. 200028. Feb. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Juni 2022

    6 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    104 SeitenLIQ10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fleet Place London EC4M 7QS zum C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB am 04. Juli 2022

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Julie Dawn Taylorson als Geschäftsführer am 04. Jan. 2022

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Canada Square London E14 5GL zum 10 Fleet Place London EC4M 7QS am 20. Dez. 2021

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bankes Lane Office Bankes Lane PO Box 9 Runcorn Cheshire WA7 4JE United Kingdom zum 15 Canada Square London E14 5GL am 06. Juli 2021

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 17. Juni 2021

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David James Horrocks am 01. Juni 2021

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom PO Box 9 Runcorn Site Hq South Parade Runcorn Cheshire WA7 4JE zum Bankes Lane Office Bankes Lane PO Box 9 Runcorn Cheshire WA7 4JE am 01. Mai 2021

    1 SeitenAD01

    Change of details for Inovyn Chlorvinyls Limited as a person with significant control on 01. Mai 2021

    2 SeitenPSC05

    Ernennung von Mr David James Horrocks als Direktor am 01. März 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Geir Tuft als Geschäftsführer am 01. März 2021

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael John Maher als Geschäftsführer am 01. März 2021

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    16 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Geir Tuft als Direktor am 01. Jan. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Edward Tane als Geschäftsführer am 01. Jan. 2020

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Re-app auditors/renumeration 05/11/2019
    RES13

    Rücktritt des Auditors

    7 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NICHOLS, Paul Frederick
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Sekretär
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    British107994610001
    HORROCKS, David James
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Geschäftsführer
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritish280500660001
    MOORCROFT, Anthony
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Geschäftsführer
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritish124489230001
    HEEMSKERK, Leonardus Hendrik
    15 Cumbers Drive
    Ness
    CH64 4AU Neston
    Cheshire
    Sekretär
    15 Cumbers Drive
    Ness
    CH64 4AU Neston
    Cheshire
    British115611110001
    PAUL, Nigel Anthony Lewis
    21/4 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    21/4 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    British93115070001
    REECE, John
    1 The Cedars
    PO16 7AJ Fareham
    Hampshire
    Sekretär
    1 The Cedars
    PO16 7AJ Fareham
    Hampshire
    British68799970001
    BROMLEY, Adrian Paige Westwood
    3 Clifton House Dee Banks
    Great Boughton
    CH3 5UU Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Clifton House Dee Banks
    Great Boughton
    CH3 5UU Chester
    Cheshire
    British67385640002
    CROTTY, Thomas Patrick
    Sunnybank Cottage
    School Lane
    CW6 9NE Bunbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Sunnybank Cottage
    School Lane
    CW6 9NE Bunbury
    Cheshire
    United KingdomIrish75282290001
    CURRIE, Andrew Christopher
    South Marden
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    South Marden
    Rhinefield Road
    SO42 7SQ Brockenhurst
    Hampshire
    British38220340001
    DECADT, Ghislain Georges Jose
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    Geschäftsführer
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    BelgiumBelgian156709860001
    HEEMSKERK, Leonardus Hendrik
    15 Cumbers Drive
    Ness
    CH64 4AU Neston
    Cheshire
    Geschäftsführer
    15 Cumbers Drive
    Ness
    CH64 4AU Neston
    Cheshire
    British115611110001
    MACLEAN, Calum Grigor
    Whitemoors
    Broadlands Road
    SO42 7SX Brockenhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Whitemoors
    Broadlands Road
    SO42 7SX Brockenhurst
    Hampshire
    United KingdomBritish71175820002
    MAHER, Michael John
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    Geschäftsführer
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    United KingdomBritish110531730009
    METCALFE, Keith
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    Geschäftsführer
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    United KingdomEnglish41304310002
    PAUL, Nigel Anthony Lewis
    21/4 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    21/4 Mid Steil
    Glenlockhart
    EH10 5XB Edinburgh
    Midlothian
    British93115070001
    REECE, John
    1 The Cedars
    PO16 7AJ Fareham
    Hampshire
    Geschäftsführer
    1 The Cedars
    PO16 7AJ Fareham
    Hampshire
    British68799970001
    REED, Ashley Julian
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    Geschäftsführer
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    United KingdomBritish105306840001
    SCHNURR, Otto, Dr
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    Geschäftsführer
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    United KingdomGerman119116670002
    TANE, Christopher Edward
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    Geschäftsführer
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    United KingdomBritish77731380001
    TAYLORSON, Julie Dawn
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    Geschäftsführer
    Fleet Place
    EC4M 7QS London
    10
    United KingdomBritish107792450002
    TRAYNOR, Anthony
    14 Lyme Grove
    WA14 2AD Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    14 Lyme Grove
    WA14 2AD Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish77423160001
    TUFT, Geir
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    Geschäftsführer
    PO BOX 9 Runcorn Site Hq
    South Parade Runcorn
    WA7 4JE Cheshire
    United KingdomNorwegian203541100002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bankes Lane
    PO BOX 9
    WA7 4JE Runcorn
    Bankes Lane Office
    Cheshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Bankes Lane
    PO BOX 9
    WA7 4JE Runcorn
    Bankes Lane Office
    Cheshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4068812
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 12. Aug. 2011
    Geliefert am 19. Aug. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form MGO1 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon barclays bank PLC re ineos chlor sales international limited euro business premium account, account number 72519677.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 17. Mai 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 14. Okt. 2005
    Geliefert am 28. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting as Security Trustee for Itself and Eachof the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Ineos security agreement dated 31 december 2003 (as amended and restated by a deed of amendment and restatement)
    Erstellt am 25. Okt. 2004
    Geliefert am 04. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and each other member of the borrower group to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first mortgage all estates or interests in any freehold or leasehold property now owned by it and by way of first fixed charge all estates or interests in any freehold or leasehold property now subsequently owned by it including all buildings fixtures fittings the benefit of any covenants by way of a first legal mortgage all shares by way of a first fixed charge its interest in all shares stocks debentures including any dividend or interest paid;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ineos Capital Limited
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security document dated 20 february 2001 as amended and restated by a deed of novation, amendment and restatement
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 20. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All of the obligations of any borrower and each other member of the borrower group and of chlor 1 and each member of the borrower group or the chlor 2 group under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Imperial Chemical Industries PLC and Ici Industrial Investments Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Ineos security agreement
    Erstellt am 31. Dez. 2003
    Geliefert am 14. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the borrower and each other member of the borrower group under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first mortgage all estates or interests in any freehold or leasehold property now owned by it and by way of first fixed charge all estates or interests in any freehold or leasehold property now subsequently owned by it including all buildings fixtures fittings the benefit of any covenants by way of a first legal mortgage all shares by way of a first fixed charge its interest in all shares stocks debentures including any dividend or interest paid. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ineos Capital Limited
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security document (the "deed") dated 20TH february, 2001 between the chargor, ineos chlor limited, ineos chlor energy limited, imperial chemical industries PLC (the "original second creditor") and imperial chemical industries PLC ("ici trustee").
    Erstellt am 20. Feb. 2001
    Geliefert am 01. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations (whether present future actual or contingent) of the borrower and each other member of the borrowing group under insofar as the lender is from time to time ici or a member of its group the ici facility agreement and the other finance documents (all as defined) and insofar as the lender is for time to time not ici or a member of its group any counter-indemnity and the security documents (all as defined) and all of the obligations whether present future actual or contingent of the borrower and each other member of the borrower group under the sale and purchase agreement (and any document entered into pursuant to or in connection with it) insofar as it relates to the cormorant business (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Imperial Chemical Industries PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Barclays security document dated 19 february 2001 and entered into by the company (formerly known as runcorn chemicals limited),ineos chlor limited,ineos chlor energy limited and barclays bank PLC
    Erstellt am 19. Feb. 2001
    Geliefert am 26. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the monies which now or at any time in future may be owing due and/or payable (but remaining unpaid) by any chargor to the original creditor under the facility agreement or any other finance document
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The "Original Creditor")
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat INOVYN SALES INTERNATIONAL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Juni 2021Beginn der Liquidation
    11. Jan. 2023Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0