EVESLEIGH (KENT) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEVESLEIGH (KENT) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03966061
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EVESLEIGH (KENT) LIMITED?

    • Betreuungseinrichtungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen (87200) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich EVESLEIGH (KENT) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Voyage Care Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EVESLEIGH (KENT) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OPUS LIVING LIMITED23. Mai 200223. Mai 2002
    ANGEVIN SPECIALIST HOMES LIMITED25. Mai 200025. Mai 2000
    SPEED 8248 LIMITED06. Apr. 200006. Apr. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EVESLEIGH (KENT) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für EVESLEIGH (KENT) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Philip Andre Sealey als Geschäftsführer am 20. Jan. 2022

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Winning als Geschäftsführer am 20. Jan. 2022

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Philip Andre Sealey als Sekretär am 20. Jan. 2022

    2 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Shaun Parker als Direktor am 06. Jan. 2022

    3 SeitenAP01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 07. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 4,499.55
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Entry into documents 18/12/2014
    RES13

    Ernennung von Mr Philip Andre Sealey als Direktor am 09. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kevin Wei Roberts als Geschäftsführer am 09. Jan. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    19 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 039660610020, erstellt am 23. Dez. 2014

    11 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 07. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 4,499.55
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    16 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Garrick House 2 Queen Street Lichfield Staffordshire WS13 6QD United Kingdom* am 25. Sept. 2013

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Kevin Wei Roberts als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von James Mckendrick als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von EVESLEIGH (KENT) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARKER, Shaun
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care Wall Island
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care Wall Island
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish100048680001
    ALFLATT, John Neal
    The Old Rectory
    St Andrew Street
    SG14 1HZ Hertford
    Sekretär
    The Old Rectory
    St Andrew Street
    SG14 1HZ Hertford
    British86320800002
    BURNETT, Nigel John
    Lone Oak
    Yew Tree Lane
    TN6 3QP Rotherfield
    East Sussex
    Sekretär
    Lone Oak
    Yew Tree Lane
    TN6 3QP Rotherfield
    East Sussex
    British35313960003
    FISHER, Michael Anthony
    77 Dale Wood Road
    BR6 0BY Orpington
    Kent
    Sekretär
    77 Dale Wood Road
    BR6 0BY Orpington
    Kent
    British70001340001
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Sekretär
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    British61663230001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Sekretär
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    176564290001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BURNS, Thomas
    27 Park Avenue North
    NN3 2HT Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    27 Park Avenue North
    NN3 2HT Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish78519600001
    DONALDSON, Neil
    Ilg - St Georges House, Knoll
    Road, Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Geschäftsführer
    Ilg - St Georges House, Knoll
    Road, Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritish172494110001
    FERRIN, Keith Anthony
    Heatherbank Woodgate Lane
    Maidstone Road Borden
    ME9 7QB Sittingbourne
    Kent
    Geschäftsführer
    Heatherbank Woodgate Lane
    Maidstone Road Borden
    ME9 7QB Sittingbourne
    Kent
    British33592200001
    GILBERT, Linda Rose
    19 Lyngs Close
    Yalding
    ME18 6JS Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    19 Lyngs Close
    Yalding
    ME18 6JS Maidstone
    Kent
    British64511610001
    GLENISTER, Paul William
    The Homestead Harbourlands
    Boxley Road, Boxley
    ME14 3DN Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    The Homestead Harbourlands
    Boxley Road, Boxley
    ME14 3DN Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish85658200001
    HAYWARD, James Duncan Henry
    Ilg - St Georges House, Knoll
    Road, Camberley
    GU15 3SY Surrey
    Geschäftsführer
    Ilg - St Georges House, Knoll
    Road, Camberley
    GU15 3SY Surrey
    EnglandBritish24500050002
    HEATH, Catherine Anne
    Lydstep
    Cornwall Gardens
    BN1 6RH Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Lydstep
    Cornwall Gardens
    BN1 6RH Brighton
    East Sussex
    British75683820002
    HEATH, Paul Russell
    7 Montpelier Villas
    BN1 3DH Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    7 Montpelier Villas
    BN1 3DH Brighton
    East Sussex
    United KingdomBritish40840100001
    HEWSON, Anthony Paul Maitland
    Old Hall Cottage The Street
    Walberton
    BN18 0PH Arundel
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Old Hall Cottage The Street
    Walberton
    BN18 0PH Arundel
    West Sussex
    EnglandBritish4514230001
    HOPKINS, Stephen Frederick
    18 Rhapsody Crescent
    Warley
    CM14 5GD Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    18 Rhapsody Crescent
    Warley
    CM14 5GD Brentwood
    Essex
    EnglandBritish42146670006
    HYATT, Gregory John
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Firs
    27 Crookham Road
    GU51 5DP Fleet
    Hampshire
    United KingdomBritish61663230001
    IRONSIDE, Linda Margaret
    The Homestead
    Boxley Road, Boxley
    ME14 3DN Maidstone
    Kent
    Geschäftsführer
    The Homestead
    Boxley Road, Boxley
    ME14 3DN Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish70197560001
    LANE, Geoffrey Roy
    Larkrise
    Redcroft Walk
    GU6 8DS Cranleigh
    Surrey
    Geschäftsführer
    Larkrise
    Redcroft Walk
    GU6 8DS Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish20198450001
    LOWE, Kenneth
    9 Pyrford Place
    Pyrford Road
    GU22 8UR Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    9 Pyrford Place
    Pyrford Road
    GU22 8UR Woking
    Surrey
    British70449230003
    MCKENDRICK, James Bruce
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    2 Queen Street
    WS13 6QD Lichfield
    Garrick House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154043480001
    MEESON, Janice Elizabeth
    Broadfields
    Argos Hill
    TN6 3QH Rotherfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Broadfields
    Argos Hill
    TN6 3QH Rotherfield
    East Sussex
    British40840150001
    O'SULLIVAN, Ian
    5 Hassendean Road
    SE3 8TR Blackheath
    Geschäftsführer
    5 Hassendean Road
    SE3 8TR Blackheath
    British77491370001
    ROBERTS, Kevin Wei
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish72030660002
    SAVAGE, Andrew
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    Geschäftsführer
    Lindisfarne The Cloisters
    Wadworth Hall Lane Wadworth
    DN11 9BH Doncaster
    EnglandBritish117869550001
    SEALEY, Philip Andre
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    EnglandBritish45325360001
    TURNER, Thelma Lucille
    5 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    Cobblers Cottage
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Bar Road North
    Beckingham
    DN10 4NN Doncaster
    Cobblers Cottage
    South Yorkshire
    United KingdomBritish170427170001
    WHITTAKER, George Anthony David
    Ketton House
    Ketton
    PE9 3TD Aldgate
    Rutland
    Geschäftsführer
    Ketton House
    Ketton
    PE9 3TD Aldgate
    Rutland
    EnglandBritish125108980001
    WINNING, Andrew
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Wall Island
    Birmingham Road
    WS14 0QP Lichfield
    Voyage Care
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish73772160002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Hat EVESLEIGH (KENT) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 23. Dez. 2014
    Geliefert am 23. Dez. 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Millstream house at 4 mill road strood rochester kent t/no.K588011 please refer to the instrument for further property charged.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Dez. 2006
    Geliefert am 29. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or other obligor to the security trustee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    128 hadlow road tonbridge t/n K363609, 130 hadlow road tonbridge t/n K763590, 4 nevil park tunbridge wells t/n K162068, for details of further properties charged, please refer to form 395,. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Feb. 2006
    Geliefert am 10. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 11 park avenue gillingham kent t/no K87551. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Juli 2005
    Geliefert am 18. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The old priory 4 mill road stroud rochester kent t/n K588011, grange court residential home maynards green heathfield east sussex t/n ESX111549, 4 nevill park tunbridge wells kent t/n K162068. For further details please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juli 2005
    Geliefert am 18. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The old priory 4 mill road stroud rochester kent t/n K588011. Grange court residential home maynards green heathfield east sussex t/n ESX111549. 4 nevill park tunbridge wells kent t/n K162068. For further details please refer to form 395. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 18. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. März 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed
    Erstellt am 01. Juli 2005
    Geliefert am 11. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All properties now owned by such company or in which such company has an interest,all present and future properties,all equipment,all securities,all debts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Equity Partnership Investment Company PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Juni 2004
    Geliefert am 18. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 4 nevill park tunbridge wells kent t/no K162068. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Mai 2003
    Geliefert am 14. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Grange court residential home maynards green east sussex t/no: ESX111549. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2003
    Geliefert am 15. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 11. März 2003
    Geliefert am 15. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 130 hadlow road tonbridge kent K763590. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Feb. 2003
    Geliefert am 13. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The old priory 4 mill road frindsbury rochester ME2 3BT. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Feb. 2003
    Geliefert am 28. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    126 hadlow road tonbridge tonbridge and malling kent t/n K692353. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 2003
    Geliefert am 08. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a rowan house dernier road tonbridge and malling kent t/n K624842. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 07. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being 126-130 hadlow rd tonbridge kent t/nos: K363609 K763590 K692353. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 07. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a grange court residential home maynards green heathfield east sussex t/no: ESX111549. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 07. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 07. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 12 park road southborough kent t/no: K255830. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 07. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 21 church lane bearsted maidstone t/no: K748766. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 07. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a rowan house dernier rd tonbridge kent t/no: K624842. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 30. Okt. 2000
    Geliefert am 07. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    4 neville park tunbridge wells kent t/no: K162068. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0