RED FUNNEL GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRED FUNNEL GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03968658
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LINKSGOOD LIMITED10. Apr. 200010. Apr. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 07. Apr. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 039686580020 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 039686580021 vollständig

    1 SeitenMR04

    Cessation of Red Funnel Group (Holdings) Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018

    1 SeitenPSC07

    Notification of Falcon Acquisitions Limited as a person with significant control on 31. Jan. 2018

    2 SeitenPSC02

    Erfüllung der Belastung 039686580022 vollständig

    1 SeitenMR04

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 31. Jan. 2018

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Share prem and cap redemption reserve cancelled 31/01/2018
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Charles John Gore Hazelwood als Geschäftsführer am 08. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Edward Arthur Wilson als Geschäftsführer am 08. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Francis Campbell als Geschäftsführer am 08. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    22 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 039686580019 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 039686580018 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 039686580017 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 039686580022, erstellt am 20. Juli 2017

    17 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 039686580020, erstellt am 20. Juli 2017

    40 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 039686580021, erstellt am 20. Juli 2017

    9 SeitenMR01

    Beendigung der Bestellung von Maria Georgina Dellacha als Geschäftsführer am 07. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Keith James Nelson als Geschäftsführer am 07. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GEORGE, Kevin Alan
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish186130710001
    WINTER, Paul Richard
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish132752850001
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Sekretär
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British8125620001
    SHEARD, John Paul
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    Sekretär
    42 Serpentine Road
    PO16 7EB Fareham
    Hampshire
    British61554710001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLAND, Christopher Donald Jack
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    Geschäftsführer
    Yafford House
    PO30 3LH Shorwell
    Isle Of Wight
    United KingdomBritish8125610001
    BRADBURY, Kenton Edward
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish147513860001
    CAMPBELL, Michael Francis
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    CanadaCanadian235365510001
    COOPER, James Nigel Shelley
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish265561970001
    DELLACHA, Maria Georgina
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish174489750001
    DOCHERTY, Thomas James
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Garden Cottage
    Fritham Court Fritham
    SO43 7HH Lyndhurst
    Hampshire
    EnglandBritish83269560002
    DUPONT, Pierre Arthur Raoul
    Flat2
    170 Holland Park
    W11 4UH London
    Geschäftsführer
    Flat2
    170 Holland Park
    W11 4UH London
    Belgian70838360002
    HAZELWOOD, Charles John Gore
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish111535480002
    HELMORE, Max David Charles
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish174349030001
    MILES, Graham John
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Willow Lodge
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    British8125620001
    NELSON, Stephen Keith James
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish179946540001
    PATON, Hugh
    30 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NP London
    Geschäftsführer
    30 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NP London
    British73255110001
    SCHUMACHER, Bernd
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandGerman169583030001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    EnglandBritish107002130001
    STOKHUYZEN, Wiet Austin
    73 Rostrevor Road
    SW6 5AR London
    Geschäftsführer
    73 Rostrevor Road
    SW6 5AR London
    British73695170002
    WHYTE, Alistair Morrison
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    11 Stoney Lane
    SO22 6DN Winchester
    Hampshire
    United KingdomBritish8125600001
    WILSON, Edward Arthur
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    Geschäftsführer
    12 Bugle Street
    Southampton
    SO14 2JY Hampshire
    United KingdomBritish214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RED FUNNEL GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Falcon Acquisitions Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    31. Jan. 2018
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer06238324
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Red Funnel Group (Holdings) Limited
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    06. Apr. 2016
    Bugle Street
    SO14 2JY Southampton
    12
    England
    Ja
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEnglish Law
    RegistrierungsortUk Company Register
    Registrierungsnummer05115188
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat RED FUNNEL GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 20. Juli 2017
    Geliefert am 31. Juli 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All current and future land (except for restricted land) (including, amongst other land, the property at 7 the arcade, cowes, PO31 7AR with title number IW51117) together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery at any time thereon, intellectual property (except for any restricted ip), and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01 (the "instrument"). For more details please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbc Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 31. Juli 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 01. Feb. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Juli 2017
    Geliefert am 27. Juli 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    A ship known as "red jet 4" (official number 906937).
    Berechtigte Personen
    • Rbc Europe Limited
    Transaktionen
    • 27. Juli 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Feb. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Juli 2017
    Geliefert am 27. Juli 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    A ship called red jet 4 with official number 906937.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbc Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 27. Juli 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 06. Feb. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juli 2016
    Geliefert am 13. Juli 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    A ship k/a "red jet 4". official number 906937.
    Berechtigte Personen
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 13. Juli 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juli 2016
    Geliefert am 12. Juli 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Freehold property at 7 the arcade cowes title number IW51117. For more details please refer to the instrument.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 12. Juli 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juli 2016
    Geliefert am 12. Juli 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Red jet 4 official number 906937.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 12. Juli 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 10. Aug. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental assignment of insurance
    Erstellt am 01. Mai 2009
    Geliefert am 07. Mai 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rights title and interest in and to the red jet 5 marine insurances and all its benefits and interests present and future therein. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A statutory ship mortgage
    Erstellt am 25. Okt. 2007
    Geliefert am 02. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel red jet 4 official number 906937.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of covenants
    Erstellt am 25. Okt. 2007
    Geliefert am 01. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest, present and future in the ship being the vessel red jet 4 (official number 906937); and the earnings and the requisition compensation and all its benefits and interest present and future therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment of insurance
    Erstellt am 25. Okt. 2007
    Geliefert am 01. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the chargor's rights, title and interest in and to the marine insurances and all its benefits and interests present and future therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 14. Mai 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 25. Okt. 2007
    Geliefert am 01. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    7 the arcade, cowes t/no. IW51117 and 8. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage of a ship
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 26. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Sixty four shares in the vessel.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Trusee) for Andon Behalf of the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 26. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenants
    Erstellt am 10. Mai 2006
    Geliefert am 26. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or the lessee to the lenders and each indemnitee or in each case any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interests present and future in and to the vessel meaning, the whole of the motor vessel 'red jet 4' registered in the name of the owner at the port of southampton under official number 906937. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Lender and Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 10. Mai 2006
    Geliefert am 20. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent for the Secured Creditors
    Transaktionen
    • 20. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Mai 2004
    Geliefert am 04. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7 fountain quay (west) cowes isle of wight t/n IW51117, 8 the arcade fountain quay (west) cowes isle of wight t/n IW51116, option to purchase land at whippingha. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Creditors)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment (relating to the passenger/car ferry bergen castle)
    Erstellt am 27. Mai 2004
    Geliefert am 04. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the owner's right title and interest present and future in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Creditors)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenants (in respect of the ship bergen castle)
    Erstellt am 27. Mai 2004
    Geliefert am 04. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its interest in and to the ship and all its right title and interest in and to the earnings the insurances charter guarantee and requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Creditors)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of a ship
    Erstellt am 27. Mai 2004
    Geliefert am 04. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £60,007,000 and all other monies due or to become due from the company to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    64/64TH shares in the ship described as bergen castle official number 907948 and in its appurtenances.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Creditors)
    Transaktionen
    • 04. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of covenant to accompany a mortgage of a ship
    Erstellt am 11. Nov. 2003
    Geliefert am 18. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £2,554,200 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed security the vessel named "red jet 4" official no 906937 including its hull, engines, instruments all other accessories and component parts thereof; all books, manuals, handbooks, technical data, drawings, schedules and other documentation belonging to the vessel; a demise charter made 11TH november 2003; all other earnings, charters, charter guarantees, insurances and requisition compensation in respect of the vessel. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Statutory mortgage of a ship
    Erstellt am 11. Nov. 2003
    Geliefert am 18. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    British vessel known as "red jet 4" official no 906937.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rfg deed of charge
    Erstellt am 21. Dez. 2001
    Geliefert am 02. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    An assignment by way of first fixed security of all right title and interest and other benefit (present and future) in, to and under the abph deed of tax covenant to the extent that such right title interest and other benefit relates to liabilities of siow or vectis including without limitation all rights to receive payments of any amounts which may become payable to it thereunder and all payments received by it thereunder all rights to serve notices and/or make demands thereunder and/or to take such steps as are required to cause payments to become due and payable thereunder and all rights ofaction in respect of any breach thereof and all rights to receive damages or obtain relief in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York (For Itself and on Behalf of the Other Red Funnel Secured Parties and Siow)
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 2000
    Geliefert am 08. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee under the finance documents and the mezzanine finance documents (as defined) and obligations due from the company to the security trustee or any of the other beneficiaries (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all tangible moveable property,the charged accounts,the intellectual property,goodwill and rights in relation to uncalled capital,the investments,all dividends,interest and other monies payable in respect of shares and other related rights and all monetary claims; the proceeds of any insurance policy and all related rights and all rights and claims in relation to any assigned account; all agreements,contracts,deeds,licences,undertakings,guarantees,covenants, warranties and other documents floating charge over all undertaking and assets,present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York as Security Trustee for the Benificiaries
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0