VARICK AND SPRING (UK) LIMITED

VARICK AND SPRING (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVARICK AND SPRING (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03971244
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    • Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    77 Oxford Street
    W1D 2ES London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MIVA (UK) LIMITED13. Juni 200513. Juni 2005
    ESPOTTING MEDIA (UK) LIMITED15. Nov. 200115. Nov. 2001
    E-SPOTTING (UK) LIMITED12. Apr. 200012. Apr. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 03. Mai 2016

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 12. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    12 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Apr. 2014

    Kapitalaufstellung am 22. Apr. 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Peter Corrao als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Peter Corrao als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    16 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    16 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , Lasenby House 32 Kingly Street, London, W1B 5QQ, United Kingdom am 27. März 2012

    1 SeitenAD01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    19 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von VARICK AND SPRING (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PISARIS, John Boyd
    1045 Bal Isle Drive
    Fort Myers
    Florida
    33919
    Usa
    Sekretär
    1045 Bal Isle Drive
    Fort Myers
    Florida
    33919
    Usa
    American120337940002
    PISARIS, John Boyd
    1045 Bal Isle Drive
    Fort Myers
    Florida
    33919
    Usa
    Geschäftsführer
    1045 Bal Isle Drive
    Fort Myers
    Florida
    33919
    Usa
    UsaAmerican120337940002
    GEBBIE, David Alexander George
    11 Sherbrook Hill
    EX9 6DA Budleigh Salterton
    Devon
    Sekretär
    11 Sherbrook Hill
    EX9 6DA Budleigh Salterton
    Devon
    British72590190003
    GOLDBERG, Stephen Jonathan
    235 St John Street
    EC1V 4NG London
    Sekretär
    235 St John Street
    EC1V 4NG London
    British2227260004
    GOLDBERG, Stephen Jonathan
    103 Bridge Lane
    NW11 0EU London
    Greater London
    Sekretär
    103 Bridge Lane
    NW11 0EU London
    Greater London
    British2227260001
    AA COMPANY SERVICES LIMITED
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    First Floor Offices 8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002630001
    ALLNER, Christopher Charles
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Childs Farm
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish78206300001
    BANCROFT COOKE, Nicholas Desmond James
    16 Ennismore Mews
    SW7 1AN London
    Geschäftsführer
    16 Ennismore Mews
    SW7 1AN London
    EnglandBritish70337890001
    BISHOP, Sebastian Luke
    Lennox Gardens
    Lower Ground Flat
    SW3 0DG London
    44
    Geschäftsführer
    Lennox Gardens
    Lower Ground Flat
    SW3 0DG London
    44
    British107286980002
    BISHOP, Sebastian Luke
    16 Randolph Road
    W9 1AN London
    Geschäftsführer
    16 Randolph Road
    W9 1AN London
    British70337920002
    BOCAN, Jeff
    28 Bramham Gardens
    Flat 16
    SW5 0HE London
    Geschäftsführer
    28 Bramham Gardens
    Flat 16
    SW5 0HE London
    British92312190002
    BUNIS, Jonathan
    Flat 10
    57 Holland Park
    W11 3RS London
    Geschäftsführer
    Flat 10
    57 Holland Park
    W11 3RS London
    American124727110001
    BURGE, Alan
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    United KingdomBritish197259620001
    CORRAO, Peter
    Simsbury Rd
    06002 Bloomfield
    500
    Ct
    U S A
    Geschäftsführer
    Simsbury Rd
    06002 Bloomfield
    500
    Ct
    U S A
    UsaU S A115277820002
    ISHAG, Daniel
    Ground Floor Flat
    19 Queens Gate
    SW7 London
    Geschäftsführer
    Ground Floor Flat
    19 Queens Gate
    SW7 London
    Italian70927420002
    ISHAG, David
    Ground Floor Flat
    19 Queens Gate
    SW7 London
    Geschäftsführer
    Ground Floor Flat
    19 Queens Gate
    SW7 London
    British79432110002
    LINDE, Carl
    13 Highfield Gardens
    NW11 9HD London
    Geschäftsführer
    13 Highfield Gardens
    NW11 9HD London
    United KingdomSouth African70746870002
    MCDONNELL, Stephen
    26 Melville Avenue
    CR2 7HY Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    26 Melville Avenue
    CR2 7HY Croydon
    Surrey
    Irish107320020001
    MCDONNELL, Stephen
    26 Melville Avenue
    CR2 7HY Croydon
    Surrey
    Geschäftsführer
    26 Melville Avenue
    CR2 7HY Croydon
    Surrey
    Irish107320020001
    PISARIS HENDERSON, Craig Allen
    11710 Rosemount Drive
    Fort Myers
    Florida 33913
    Usa
    Geschäftsführer
    11710 Rosemount Drive
    Fort Myers
    Florida 33913
    Usa
    Us Citizen99452240002
    POULTER, Adam
    Waytefield
    9 Long Wood Drive
    HP9 2SS Jordans
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Waytefield
    9 Long Wood Drive
    HP9 2SS Jordans
    Buckinghamshire
    British114157480001
    ROBINSON, Lowell
    470 West End Avenue
    Apartment 2e
    10024 New York
    New York 10024
    Usa
    Geschäftsführer
    470 West End Avenue
    Apartment 2e
    10024 New York
    New York 10024
    Usa
    American73871170001
    SEIPPEL, William
    190 Inwood Terrace
    Roswell Ga
    Fulton 30075
    U S A
    Geschäftsführer
    190 Inwood Terrace
    Roswell Ga
    Fulton 30075
    U S A
    U S A American115277080001
    TAYLOR, Michael Todd
    Circa Apartments
    202 Regents Park Road
    NW1 8AD London
    Geschäftsführer
    Circa Apartments
    202 Regents Park Road
    NW1 8AD London
    American120383420001
    THUNE, Phillip Ross
    7885 Go Canes Way
    Fort Myers
    Florida 33912
    Usa
    Geschäftsführer
    7885 Go Canes Way
    Fort Myers
    Florida 33912
    Usa
    Us Citizen99452160001
    BUYVIEW LTD
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    1st Floor Offices
    8-10 Stamford Hill
    N16 6XZ London
    900002620001

    Hat VARICK AND SPRING (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 07. Nov. 2008
    Geliefert am 13. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bridge Bank N.A.
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge of deposit
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 01. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation 20709862 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 2003
    Geliefert am 15. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or the parent to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Findwhat.Com
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 2003
    Geliefert am 23. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Peter V Miller Acting for Himself and as Trustee on Behalf of the Noteholders Under Theconvertible Loan Note Instrument (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of variation and amendment to debenture
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 16. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (For variation to charge see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Proven Private Equity Limited
    Transaktionen
    • 16. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of variation and amendment to b notes debenture
    Erstellt am 08. Nov. 2002
    Geliefert am 16. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (For variations to charge see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Proven Private Equity Limited
    Transaktionen
    • 16. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2002
    Geliefert am 09. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All assets of the company as defined in the charge other than monies from time to time held subject to the terms of the escrow agreement.
    Berechtigte Personen
    • Dynamic Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Aug. 2002
    Geliefert am 05. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Proven Private Equity Limited (Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Noteholders,the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of variation and amendment to the debenture dated 6 december 2001
    Erstellt am 19. Aug. 2002
    Geliefert am 05. Sept. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the proprety assets and undertaking of the chargor including book debts goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Proven Private Equity Limited (Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Noteholders,the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Escrow agreement
    Erstellt am 01. Aug. 2002
    Geliefert am 08. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Subject to the provisions of clause 5 of the agreement, all its rights in the escrow account to yahoo!. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yahoo! UK Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Dez. 2001
    Geliefert am 08. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to or as evidenced by the loan notes (as defined in the debenture) and/or the loan note instrument (as defined in the debenture) and/or the subscription agreement (as defined in the debenture) and/or this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Proven Private Equity Limited,as Security Trustee and Its Successors
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0