CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED

CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03974061
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WILMSLOW (NO.6) GENERAL PARTNER LIMITED26. Juni 200026. Juni 2000
    SHELFCO (NO.1895) LIMITED17. Apr. 200017. Apr. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Apr. 2022

    8 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET England zum 30 Finsbury Square London EC2A 1AG am 15. Apr. 2021

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 07. Apr. 2021

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Jennifer Anne Lisbey als Geschäftsführer am 28. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Ms Jennifer Anne Lisbey als Direktor am 23. Aug. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Matthew James Torode als Geschäftsführer am 23. Aug. 2019

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018

    33 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Matthew James Torode als Direktor am 03. Mai 2018

    2 SeitenAP01

    Change of details for Britel Fund Nominees Limited as a person with significant control on 16. Mai 2017

    2 SeitenPSC05

    Änderung der Details des Direktors für Mr Benjamin John Tolhurst am 31. Jan. 2018

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Raymond Andrew Darroch am 31. Jan. 2018

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017

    35 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Hermes Secretariat Limited am 31. Jan. 2018

    1 SeitenCH04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ zum Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET am 31. Jan. 2018

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016

    35 SeitenAA

    Ernennung von Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman als Direktor am 23. März 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HERMES SECRETARIAT LIMITED
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Sekretär
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer03717842
    93700910001
    DARROCH, Christopher Raymond Andrew
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Geschäftsführer
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    ScotlandBritishFund Manager81530460007
    TOLHURST, Benjamin John
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Geschäftsführer
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    EnglandBritishChartered Surveyor155162050001
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    Geschäftsführer
    Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    30
    United KingdomBritishChartered Accountant155163600003
    SHELLEY, Leon
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    Sekretär
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    British115567560003
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Sekretär
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    ALLEN, Peter Kenneth
    88 Cremorne Road
    Cremorne
    Sydney
    New South Wales 2090
    Australia
    Geschäftsführer
    88 Cremorne Road
    Cremorne
    Sydney
    New South Wales 2090
    Australia
    BritishDirector69229480002
    COURTAULD, Toby Augustine
    45a Moreton Street
    SW1V 2NY London
    Geschäftsführer
    45a Moreton Street
    SW1V 2NY London
    BritishChartered Surveyor46882260003
    DEWHIRST, Andrew David
    19 The Ridgeway
    EN2 8NX Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    19 The Ridgeway
    EN2 8NX Enfield
    Middlesex
    BritishAccountant29539910002
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Geschäftsführer
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant108586450001
    GUTMAN, Michael Joseph
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    Geschäftsführer
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    United KingdomAustralianCompany Director130479490009
    JOSEPH, Polly Rose
    12 Worcester Road
    SW19 7QG London
    Geschäftsführer
    12 Worcester Road
    SW19 7QG London
    United KingdomBritishSolicitor167454360001
    LISBEY, Jennifer Anne
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant259968930001
    LOW, Richard Anthony
    17 Little Dorrit
    CM1 4YQ Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    17 Little Dorrit
    CM1 4YQ Chelmsford
    Essex
    BritishCompany Director2748160001
    MACKRILL, Brian James
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    Geschäftsführer
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    BritishCompany Director119228590001
    MARTIN, Andrew John, Mr.
    Hazelryst Rystwood Road
    RH18 5LX Forest Row
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Hazelryst Rystwood Road
    RH18 5LX Forest Row
    East Sussex
    EnglandBritishChartered Surveyor3565840001
    MCGARRITY, Stewart
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Clearwell Cottage
    Boulters Lane
    SL6 8TJ Maidenhead
    Berkshire
    BritishChartered Accountant65801380001
    MILLER, Peter Howard
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    Geschäftsführer
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    Australian128485730003
    MOUSLEY, Emily Ann
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    C/O Hermes Real Estate Investment Management Ltd
    England
    England
    Geschäftsführer
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    C/O Hermes Real Estate Investment Management Ltd
    England
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant155262770001
    O'SULLIVAN, John Joseph
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    Geschäftsführer
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    IrishChartered Surveyor81874630001
    O'SULLIVAN, John Joseph
    208 Leesons Hill
    BR7 6QH Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    208 Leesons Hill
    BR7 6QH Chislehurst
    Kent
    IrishChartered Surveyor81874630001
    PIERCE, Graham Charles
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    C/O Hermes Real Estate Investment Management Ltd
    England
    England
    Geschäftsführer
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    C/O Hermes Real Estate Investment Management Ltd
    England
    England
    United KingdomUkAccountant123665160001
    SLAVIN, Philip Simon
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    Geschäftsführer
    C/O Westfield Shoppingtowns
    Limited Level 6 Mid City Place
    WC1V 6EA 71 High Holborn
    London
    United KingdomBritishChartered Accountant 140633010002
    TORODE, Matthew James, Mr.
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    Sixth Floor, 150
    England
    EnglandBritishChartered Accountant196412900002
    WATTERS, Iain Russell
    Laurel Bank
    Poyle Lane
    SL1 8LA Burnham Slough
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Laurel Bank
    Poyle Lane
    SL1 8LA Burnham Slough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3717820002
    WATTERS, Iain Russell
    Laurel Bank
    Poyle Lane
    SL1 8LA Burnham Slough
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Laurel Bank
    Poyle Lane
    SL1 8LA Burnham Slough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3717820002
    WRAY, Paul Thomas
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    C/O Hermes Real Estate Management Ltd
    England
    England
    Geschäftsführer
    Lloyds Chambers
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    C/O Hermes Real Estate Management Ltd
    England
    England
    United KingdomBritishChartered Surveyor154681480001
    MIKJON LIMITED
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    Geschäftsführer
    Lacon House 84 Theobald's Road
    WC1X 8RW London
    72341560001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Britel Fund Nominees Limited
    17 Crosswall
    EC3N 2LB London
    One America Square
    England
    06. Apr. 2016
    17 Crosswall
    EC3N 2LB London
    One America Square
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer01705288
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    The borrower debenture
    Erstellt am 25. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1) castlecourt shopping centre belfast t/n AN20356 plus unregistered land, 2) mill gate shopping centre bury, t/n GM801433, GM801435, GM851187, 3) the friary shopping centre, guildford (including 18/19, 24-33 commercial road; 4-10, 15, 90-100, 105-109, studio 1-2 cinemas woodbridge road; 5-10 leapale road; 16-18, 81-87 north street (and land to the north and north east side of north street), 171-173 high street and 105-109 bridge road, t/ns SY474266, SY635794, SY610850; see form 395 for other t/ns charged; fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and 1) castlecourt shopping centre belfast t/n AN20356 plus unregistered land, 2) mill gate shopping centre bury, t/n GM801433, GM801435, GM851187, 3) the friary shopping centre, guildford (including 18/19, 24-33 commercial road; 4-10, 15, 90-100, 105-109, studio 1-2 cinemas woodbridge road; 5-10 leapale road; 16-18, 81-87 north street (and land to the north and north east side of north street), 171-173 high street and 105-109 bridge road, t/ns SY474266, SY635794, SY610850; see form 395 for other t/ns charged; fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Calyon as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    The borrower debenture
    Erstellt am 25. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    1) castlecourt shopping centre belfast t/n AN20356 plus unregistered land, 2) mill gate shopping centre bury, t/n GM801433, GM801435, GM851187, 3) the friary shopping centre, guildford (including 18/19, 24-33 commercial road; 4-10, 15, 90-100, 105-109, studio 1-2 cinemas woodbridge road; 5-10 leapale road; 16-18, 81-87 north street (and land to the north and north east side of north street), 171-173 high street and 105-109 bridge road, t/ns SY474266, SY635794, SY610850; see form 395 for other t/ns charged; fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Calyon as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The 'northern ireland' borrower debenture
    Erstellt am 25. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Folio an 20356 county borough of belfast all the lands at west street/millfield in the city of belfast all the lands at gresham street in the city of belfast fixed and floating charges over the undertaking and all property (situated in northern ireland) and all assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Calyon as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    The 'northern ireland' borrower debenture
    Erstellt am 25. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Folio an 20356 county borough of belfast all the lands at west street/millfield in the city of belfast all the lands at gresham street in the city of belfast fixed and floating charges over the undertaking and all property (situated in northern ireland) and all assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Calyon as Security Trustee
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General partner debenture
    Erstellt am 12. Okt. 2004
    Geliefert am 14. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The royal victoria place shopping centre at calverley road goods station road victoria road and camden road tunbridge wells kent being comprised of l/h and f/h land. All plant and machinery, all benefits in respect of the insurances, all book and other debts, its goodwill, all loan capital, the benefit of all licences, its uncalled capital and its rights under any appointment of a managing agent of the property .by way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned and the interest in all moneys standing to the credit of any account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Capital Services Inc.
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture made between (1) the company (in its own capacity and in its capacity as the general partner of the wilmslow (no. 6) limited partnership) and (2) morgan stanley mortgage servicing limited (the "security trustee").
    Erstellt am 28. Sept. 2000
    Geliefert am 04. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the borrowers (as defined) or any of them to all or any of the secured parties from time to time under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Apr. 2021Beginn der Liquidation
    08. Feb. 2023Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sean Kenneth Croston
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0