CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03974061 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 30 Finsbury Square EC2A 1AG London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
WILMSLOW (NO.6) GENERAL PARTNER LIMITED | 26. Juni 2000 | 26. Juni 2000 |
SHELFCO (NO.1895) LIMITED | 17. Apr. 2000 | 17. Apr. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Apr. 2022 | 8 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET England zum 30 Finsbury Square London EC2A 1AG am 15. Apr. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Anne Lisbey als Geschäftsführer am 28. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Jennifer Anne Lisbey als Direktor am 23. Aug. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew James Torode als Geschäftsführer am 23. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 33 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew James Torode als Direktor am 03. Mai 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Change of details for Britel Fund Nominees Limited as a person with significant control on 16. Mai 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Benjamin John Tolhurst am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Christopher Raymond Andrew Darroch am 31. Jan. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Hermes Secretariat Limited am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ zum Sixth Floor, 150 Cheapside London EC2V 6ET am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Kirsty Ann-Marie Wilman als Direktor am 23. März 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERMES SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | Cheapside EC2V 6ET London Sixth Floor, 150 England |
| 93700910001 | ||||||||||
DARROCH, Christopher Raymond Andrew | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | Scotland | British | Fund Manager | 81530460007 | ||||||||
TOLHURST, Benjamin John | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | England | British | Chartered Surveyor | 155162050001 | ||||||||
WILMAN, Kirsty Ann-Marie | Geschäftsführer | Finsbury Square EC2A 1AG London 30 | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 155163600003 | ||||||||
SHELLEY, Leon | Sekretär | C/O Westfield Shoppingtowns Limited Level 6 Mid City Place WC1V 6EA 71 High Holborn London | British | 115567560003 | ||||||||||
EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||
ALLEN, Peter Kenneth | Geschäftsführer | 88 Cremorne Road Cremorne Sydney New South Wales 2090 Australia | British | Director | 69229480002 | |||||||||
COURTAULD, Toby Augustine | Geschäftsführer | 45a Moreton Street SW1V 2NY London | British | Chartered Surveyor | 46882260003 | |||||||||
DEWHIRST, Andrew David | Geschäftsführer | 19 The Ridgeway EN2 8NX Enfield Middlesex | British | Accountant | 29539910002 | |||||||||
EAST, Stephen John | Geschäftsführer | White Ladies Birch Hill Shirley Hills CR0 5HT Surrey | England | British | Chartered Accountant | 108586450001 | ||||||||
GUTMAN, Michael Joseph | Geschäftsführer | C/O Westfield Shoppingtowns Limited Level 6 Mid City Place WC1V 6EA 71 High Holborn London | United Kingdom | Australian | Company Director | 130479490009 | ||||||||
JOSEPH, Polly Rose | Geschäftsführer | 12 Worcester Road SW19 7QG London | United Kingdom | British | Solicitor | 167454360001 | ||||||||
LISBEY, Jennifer Anne | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6ET London Sixth Floor, 150 England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 259968930001 | ||||||||
LOW, Richard Anthony | Geschäftsführer | 17 Little Dorrit CM1 4YQ Chelmsford Essex | British | Company Director | 2748160001 | |||||||||
MACKRILL, Brian James | Geschäftsführer | C/O Westfield Shoppingtowns Limited Level 6 Mid City Place WC1V 6EA 71 High Holborn London | British | Company Director | 119228590001 | |||||||||
MARTIN, Andrew John, Mr. | Geschäftsführer | Hazelryst Rystwood Road RH18 5LX Forest Row East Sussex | England | British | Chartered Surveyor | 3565840001 | ||||||||
MCGARRITY, Stewart | Geschäftsführer | Clearwell Cottage Boulters Lane SL6 8TJ Maidenhead Berkshire | British | Chartered Accountant | 65801380001 | |||||||||
MILLER, Peter Howard | Geschäftsführer | C/O Westfield Shoppingtowns Limited Level 6 Mid City Place WC1V 6EA 71 High Holborn London | Australian | 128485730003 | ||||||||||
MOUSLEY, Emily Ann | Geschäftsführer | Lloyds Chambers 1 Portsoken Street E1 8HZ London C/O Hermes Real Estate Investment Management Ltd England England | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 155262770001 | ||||||||
O'SULLIVAN, John Joseph | Geschäftsführer | C/O Westfield Shoppingtowns Limited Level 6 Mid City Place WC1V 6EA 71 High Holborn London | Irish | Chartered Surveyor | 81874630001 | |||||||||
O'SULLIVAN, John Joseph | Geschäftsführer | 208 Leesons Hill BR7 6QH Chislehurst Kent | Irish | Chartered Surveyor | 81874630001 | |||||||||
PIERCE, Graham Charles | Geschäftsführer | Lloyds Chambers 1 Portsoken Street E1 8HZ London C/O Hermes Real Estate Investment Management Ltd England England | United Kingdom | Uk | Accountant | 123665160001 | ||||||||
SLAVIN, Philip Simon | Geschäftsführer | C/O Westfield Shoppingtowns Limited Level 6 Mid City Place WC1V 6EA 71 High Holborn London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 140633010002 | ||||||||
TORODE, Matthew James, Mr. | Geschäftsführer | Cheapside EC2V 6ET London Sixth Floor, 150 England | England | British | Chartered Accountant | 196412900002 | ||||||||
WATTERS, Iain Russell | Geschäftsführer | Laurel Bank Poyle Lane SL1 8LA Burnham Slough Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 3717820002 | ||||||||
WATTERS, Iain Russell | Geschäftsführer | Laurel Bank Poyle Lane SL1 8LA Burnham Slough Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 3717820002 | ||||||||
WRAY, Paul Thomas | Geschäftsführer | Lloyds Chambers 1 Portsoken Street E1 8HZ London C/O Hermes Real Estate Management Ltd England England | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 154681480001 | ||||||||
MIKJON LIMITED | Geschäftsführer | Lacon House 84 Theobald's Road WC1X 8RW London | 72341560001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britel Fund Nominees Limited | 06. Apr. 2016 | 17 Crosswall EC3N 2LB London One America Square England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
The borrower debenture | Erstellt am 25. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 1) castlecourt shopping centre belfast t/n AN20356 plus unregistered land, 2) mill gate shopping centre bury, t/n GM801433, GM801435, GM851187, 3) the friary shopping centre, guildford (including 18/19, 24-33 commercial road; 4-10, 15, 90-100, 105-109, studio 1-2 cinemas woodbridge road; 5-10 leapale road; 16-18, 81-87 north street (and land to the north and north east side of north street), 171-173 high street and 105-109 bridge road, t/ns SY474266, SY635794, SY610850; see form 395 for other t/ns charged; fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and 1) castlecourt shopping centre belfast t/n AN20356 plus unregistered land, 2) mill gate shopping centre bury, t/n GM801433, GM801435, GM851187, 3) the friary shopping centre, guildford (including 18/19, 24-33 commercial road; 4-10, 15, 90-100, 105-109, studio 1-2 cinemas woodbridge road; 5-10 leapale road; 16-18, 81-87 north street (and land to the north and north east side of north street), 171-173 high street and 105-109 bridge road, t/ns SY474266, SY635794, SY610850; see form 395 for other t/ns charged; fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
The borrower debenture | Erstellt am 25. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 1) castlecourt shopping centre belfast t/n AN20356 plus unregistered land, 2) mill gate shopping centre bury, t/n GM801433, GM801435, GM851187, 3) the friary shopping centre, guildford (including 18/19, 24-33 commercial road; 4-10, 15, 90-100, 105-109, studio 1-2 cinemas woodbridge road; 5-10 leapale road; 16-18, 81-87 north street (and land to the north and north east side of north street), 171-173 high street and 105-109 bridge road, t/ns SY474266, SY635794, SY610850; see form 395 for other t/ns charged; fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
The 'northern ireland' borrower debenture | Erstellt am 25. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Folio an 20356 county borough of belfast all the lands at west street/millfield in the city of belfast all the lands at gresham street in the city of belfast fixed and floating charges over the undertaking and all property (situated in northern ireland) and all assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
The 'northern ireland' borrower debenture | Erstellt am 25. Juli 2005 Geliefert am 04. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Folio an 20356 county borough of belfast all the lands at west street/millfield in the city of belfast all the lands at gresham street in the city of belfast fixed and floating charges over the undertaking and all property (situated in northern ireland) and all assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
General partner debenture | Erstellt am 12. Okt. 2004 Geliefert am 14. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The royal victoria place shopping centre at calverley road goods station road victoria road and camden road tunbridge wells kent being comprised of l/h and f/h land. All plant and machinery, all benefits in respect of the insurances, all book and other debts, its goodwill, all loan capital, the benefit of all licences, its uncalled capital and its rights under any appointment of a managing agent of the property .by way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned and the interest in all moneys standing to the credit of any account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture made between (1) the company (in its own capacity and in its capacity as the general partner of the wilmslow (no. 6) limited partnership) and (2) morgan stanley mortgage servicing limited (the "security trustee"). | Erstellt am 28. Sept. 2000 Geliefert am 04. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of the borrowers (as defined) or any of them to all or any of the secured parties from time to time under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat CARRAWAY TUNBRIDGE WELLS GENERAL PARTNER LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0