CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 03974945 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 76 Hagley Road Birmingham B16 8LU West Midlands |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
STOFORD (EDGBASTON) LIMITED | 19. Juni 2000 | 19. Juni 2000 |
BROOMCO (2181) LIMITED | 17. Apr. 2000 | 17. Apr. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 05. Apr. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Richard Allen als Geschäftsführer am 30. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2011 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Allen am 06. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Allen am 06. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Samuel Wilton Lee am 01. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 30 Seiten | MA | ||||||||||
Satzungsänderung durch Gesetzgebung | 2 Seiten | CC05 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Povall als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Bunbury als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Nicholson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Wilks als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Bunbury als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Euan Anstruther-Gough-Calthorpe Bt als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Martin Brennan Woolhouse als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Lee als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Samuel Wilton Lee als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOLHOUSE, Martin Brennan | Sekretär | Howards Meadow Kings Cliffe PE8 6YJ Peterborough 7 Northamptonshire United Kingdom | 146490690001 | |||||||
LEE, Mark Samuel Wilton | Geschäftsführer | 76 Hagley Road Birmingham B16 8LU West Midlands | England | British | Chief Financial Officer | 54866930002 | ||||
LEE, Mark Samuel Wilton | Sekretär | Chadwick End Farm Oldwich Lane West Chadwick End B93 0BH Solihull West Midlands | British | Company Director | 54866930001 | |||||
READMAN, Alison Mary | Sekretär | 12 Prince Rupert's Way WS13 7ER Lichfield | British | 69382380002 | ||||||
STOKES, Dominic Peter | Sekretär | 113 Norton Road DY8 2RP Stourbridge West Midlands | British | Property Developer | 88206250001 | |||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
ALLEN, John Richard | Geschäftsführer | 76 Hagley Road Birmingham B16 8LU West Midlands | England | British | Chief Executive | 71282600003 | ||||
ANSTRUTHER-GOUGH-CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir | Geschäftsführer | Elvetham Estate Office/Farm House Hartley Wintney RG27 8AW Hook Hampshire | England | British | Property Manager | 77322700001 | ||||
BUNBURY, Michael William, Sir | Geschäftsführer | Flat 3 19 Redcliffe Square SW10 9LA London | England | British | Company Director | 70449390001 | ||||
LEA, Miles Christopher | Geschäftsführer | Fir Lodge Brake Mill Hagley DY8 2XY Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | Propery Developer | 37824560002 | ||||
NICHOLSON, Charles Christian, Sir | Geschäftsführer | Turners Green Farm Elvetham RG27 8BE Hook Hampshire | England | British | Company Executive | 43226700001 | ||||
PICK, Graham John | Geschäftsführer | Hellier Drive Wombourne WV5 8AH Wolverhampton 3 Staffordshire | England | British | Chartered Accountant | 139309010001 | ||||
POVALL, David Edward | Geschäftsführer | St. Peters Road Harborne B17 0AU Birmingham 45 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | Commercial Director | 111052510002 | ||||
STOKES, Dominic Peter | Geschäftsführer | 113 Norton Road DY8 2RP Stourbridge West Midlands | England | British | Property Developer | 88206250001 | ||||
WILKS, William Henry George | Geschäftsführer | 22 Cranmer Court Sloane Avenue SW3 3HN London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 109579700001 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Hat CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and | Erstellt am 17. Sept. 2007 Geliefert am 02. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Dez. 2006 Geliefert am 21. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property k/a calthorpe house and edgbaston shopping centre, hagley road, edgbaston, birmingham t/n WM434092. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and | Erstellt am 06. Jan. 2006 Geliefert am 12. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002 | Erstellt am 29. Nov. 2005 Geliefert am 13. Dez. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/02 | Erstellt am 23. Juli 2003 Geliefert am 08. Aug. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the agreement to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Juli 2003 Geliefert am 23. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property with t/n WM434092. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2000 Geliefert am 29. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Aug. 2000 Geliefert am 19. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargees in their capacity as the trustees of the niall anstruther-gough-calthorpe discretionary settlement | |
Kurze Angaben L/H property k/a calthorpe house and edgbaston shopping centre hagley road edgbaston birmingham t/no WM434092 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0