CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED

CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03974945
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    76 Hagley Road
    Birmingham
    B16 8LU West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STOFORD (EDGBASTON) LIMITED19. Juni 200019. Juni 2000
    BROOMCO (2181) LIMITED17. Apr. 200017. Apr. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis05. Apr. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von John Richard Allen als Geschäftsführer am 30. Sept. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Feb. 2012

    Kapitalaufstellung am 02. Feb. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2011

    18 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Allen am 06. Juni 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr John Richard Allen am 06. Juni 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Samuel Wilton Lee am 01. Juni 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2010

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    30 SeitenMA

    Satzungsänderung durch Gesetzgebung

    2 SeitenCC05

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von David Povall als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Bunbury als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Charles Nicholson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von William Wilks als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael Bunbury als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Euan Anstruther-Gough-Calthorpe Bt als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Martin Brennan Woolhouse als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Lee als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Mark Samuel Wilton Lee als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WOOLHOUSE, Martin Brennan
    Howards Meadow
    Kings Cliffe
    PE8 6YJ Peterborough
    7
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Howards Meadow
    Kings Cliffe
    PE8 6YJ Peterborough
    7
    Northamptonshire
    United Kingdom
    146490690001
    LEE, Mark Samuel Wilton
    76 Hagley Road
    Birmingham
    B16 8LU West Midlands
    Geschäftsführer
    76 Hagley Road
    Birmingham
    B16 8LU West Midlands
    EnglandBritishChief Financial Officer54866930002
    LEE, Mark Samuel Wilton
    Chadwick End Farm Oldwich Lane West
    Chadwick End
    B93 0BH Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    Chadwick End Farm Oldwich Lane West
    Chadwick End
    B93 0BH Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director54866930001
    READMAN, Alison Mary
    12 Prince Rupert's Way
    WS13 7ER Lichfield
    Sekretär
    12 Prince Rupert's Way
    WS13 7ER Lichfield
    British69382380002
    STOKES, Dominic Peter
    113 Norton Road
    DY8 2RP Stourbridge
    West Midlands
    Sekretär
    113 Norton Road
    DY8 2RP Stourbridge
    West Midlands
    BritishProperty Developer88206250001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    ALLEN, John Richard
    76 Hagley Road
    Birmingham
    B16 8LU West Midlands
    Geschäftsführer
    76 Hagley Road
    Birmingham
    B16 8LU West Midlands
    EnglandBritishChief Executive71282600003
    ANSTRUTHER-GOUGH-CALTHORPE BT, Euan Hamilton, Sir
    Elvetham Estate Office/Farm House
    Hartley Wintney
    RG27 8AW Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Elvetham Estate Office/Farm House
    Hartley Wintney
    RG27 8AW Hook
    Hampshire
    EnglandBritishProperty Manager77322700001
    BUNBURY, Michael William, Sir
    Flat 3
    19 Redcliffe Square
    SW10 9LA London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    19 Redcliffe Square
    SW10 9LA London
    EnglandBritishCompany Director70449390001
    LEA, Miles Christopher
    Fir Lodge
    Brake Mill Hagley
    DY8 2XY Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Fir Lodge
    Brake Mill Hagley
    DY8 2XY Stourbridge
    West Midlands
    United KingdomBritishPropery Developer37824560002
    NICHOLSON, Charles Christian, Sir
    Turners Green Farm
    Elvetham
    RG27 8BE Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Turners Green Farm
    Elvetham
    RG27 8BE Hook
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Executive43226700001
    PICK, Graham John
    Hellier Drive
    Wombourne
    WV5 8AH Wolverhampton
    3
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Hellier Drive
    Wombourne
    WV5 8AH Wolverhampton
    3
    Staffordshire
    EnglandBritishChartered Accountant139309010001
    POVALL, David Edward
    St. Peters Road
    Harborne
    B17 0AU Birmingham
    45
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    St. Peters Road
    Harborne
    B17 0AU Birmingham
    45
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishCommercial Director111052510002
    STOKES, Dominic Peter
    113 Norton Road
    DY8 2RP Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    113 Norton Road
    DY8 2RP Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritishProperty Developer88206250001
    WILKS, William Henry George
    22 Cranmer Court
    Sloane Avenue
    SW3 3HN London
    Geschäftsführer
    22 Cranmer Court
    Sloane Avenue
    SW3 3HN London
    United KingdomBritishChartered Accountant109579700001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Hat CALTHORPE HOUSE INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27TH june 2002 and
    Erstellt am 17. Sept. 2007
    Geliefert am 02. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 11. Dez. 2006
    Geliefert am 21. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a calthorpe house and edgbaston shopping centre, hagley road, edgbaston, birmingham t/n WM434092. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sir Charles Christian Nicholson Bt, Sir Michael William Bunbury Bt Kcvo, William Henry Georgewilks and Sir Euan Hamilton Anstruther-Gough-Calthorpe Bt, Being the Trustees of the Calthorpe 1994 Continuation Fund
    Transaktionen
    • 21. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27 june 2002 and
    Erstellt am 06. Jan. 2006
    Geliefert am 12. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/2002
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 13. Dez. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 27/06/02
    Erstellt am 23. Juli 2003
    Geliefert am 08. Aug. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the agreement to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 21. Juli 2003
    Geliefert am 23. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property with t/n WM434092. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2000
    Geliefert am 29. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Aug. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2000
    Geliefert am 19. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees in their capacity as the trustees of the niall anstruther-gough-calthorpe discretionary settlement
    Kurze Angaben
    L/H property k/a calthorpe house and edgbaston shopping centre hagley road edgbaston birmingham t/no WM434092 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Sir Charles Christian Nicholson Bt, Sir Michael William Bunbury Bt and William George Henry Wilks Esq
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Jan. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0