HLI (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HLI (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03976900 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HLI (UK) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HLI (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HLI (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HAWKESBY HARGREAVES LANSDOWN LIMITED | 05. Juli 2000 | 05. Juli 2000 |
| QUAYSHELFCO 766 LIMITED | 19. Apr. 2000 | 19. Apr. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HLI (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HLI (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN zum 15 Canada Square London E14 5GL am 10. Dez. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 03. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 03. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 039769000007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Antonios Erotocritou als Direktor am 02. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Mugge als Geschäftsführer am 02. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Christopher Ross als Direktor am 20. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 20. Dez. 2016 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jennifer Owens als Sekretär am 01. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Stephen Mugge am 25. Nov. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Stephen Mugge als Direktor am 11. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Egan als Geschäftsführer am 14. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HLI (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOURIET, Geoffrey Costerton | Sekretär | Canada Square E14 5GL London 15 | 249087580001 | |||||||
| EROTOCRITOU, Antonios | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Cypriot | 167795710001 | |||||
| ROSS, David Christopher | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | Irish | 222326970001 | |||||
| AUSTIN, Vita Karen | Sekretär | 55 Moorcroft Road Hutton BS24 9SD Weston Super Mare Avon | British | 68336800002 | ||||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Sekretär | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | British | 117669700002 | ||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Sekretär | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent | 221975500001 | |||||||
| OSBORNE, David Anthony | Sekretär | 24 Foye House Bridge Road, Leigh Woods BS8 3PE Bristol | British | 70785220001 | ||||||
| OWENS, Jennifer | Sekretär | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | 183323150001 | |||||||
| NQH (CO SEC) LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Narrow Quay House Narrow Quay BS1 4AH Bristol | 900001160001 | |||||||
| BARR, Graham Maxwell | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | 125097020001 | |||||
| BROWN, Roger Michael | Geschäftsführer | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | 134140540001 | |||||
| BRUCE, David James | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | 171398800001 | |||||
| CLARK, Samuel Thomas Budgen | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 149939610001 | |||||
| EGAN, Scott | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 170703910001 | |||||
| GILLETT, Martyn Malcolm | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | 68329930003 | |||||
| HAWKESBY, Philip Paul | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 32278560001 | |||||
| HODGES, Mark Steven | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | United Kingdom | British | 58444370003 | |||||
| HOUSE, David Alan Robert | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 68330030001 | |||||
| HOYLE, James Shaw | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | English | 43124960001 | |||||
| JOHNSON, Timothy David | Geschäftsführer | The Green Westerham TN16 1AS Kent Nursery Cottage 3a | England | British | 129538180001 | |||||
| LANSDOWN, Stephen Philip | Geschäftsführer | Chapters Stoke Park Road South BS9 1LS Sneyd Park Bristol | Guernsey, Channel Islands | British | 142340880002 | |||||
| LYONS, Alastair David | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent | England | British | 193700420001 | |||||
| MUGGE, Mark Stephen | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent | England | British | 162920630005 | |||||
| PARK, Bryan | Geschäftsführer | Gate House Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Kent United Kingdom | England | British | 113694470002 | |||||
| REA, Michael Peter | Geschäftsführer | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Tower Gate House Kent England | England | British | 147194830001 | |||||
| SHOTTER, Stephen | Geschäftsführer | Staceys Street ME14 1ST Maidstone 2 County Gate Kent | England | British | 68329810001 | |||||
| NQH LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Narrow Quay House Narrow Quay BS1 4AH Bristol | 900001150001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HLI (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portishead Insurance Management Limited | 06. Apr. 2016 | Eclipse Park, Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House Kent England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HLI (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 02. Apr. 2015 Geliefert am 22. Apr. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 10. Mai 2013 Geliefert am 23. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Pursuant to the charge:. The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed | Erstellt am 27. Juni 2012 Geliefert am 07. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juni 2012 Geliefert am 06. Juli 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2010 Geliefert am 18. Sept. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 29. Apr. 2009 Geliefert am 06. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 21. Juli 2000 Geliefert am 27. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HLI (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0