HLI (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHLI (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03976900
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HLI (UK) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich HLI (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HLI (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HAWKESBY HARGREAVES LANSDOWN LIMITED05. Juli 200005. Juli 2000
    QUAYSHELFCO 766 LIMITED19. Apr. 200019. Apr. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HLI (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für HLI (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN zum 15 Canada Square London E14 5GL am 10. Dez. 2018

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 08. Nov. 2018

    LRESSP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 03. Aug. 2018

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Geoffrey Costerton Gouriet als Sekretär am 03. Aug. 2018

    2 SeitenAP03

    Erfüllung der Belastung 039769000007 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Antonios Erotocritou als Direktor am 02. März 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Mugge als Geschäftsführer am 02. März 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Apr. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr David Christopher Ross als Direktor am 20. Dez. 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Jacqueline Anne Gregory als Sekretär am 20. Dez. 2016

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 13. Mai 2016

    • Kapital: GBP 772,919
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Jennifer Owens als Sekretär am 01. März 2016

    1 SeitenTM02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Stephen Mugge am 25. Nov. 2015

    2 SeitenCH01

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Mark Stephen Mugge als Direktor am 11. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Scott Egan als Geschäftsführer am 14. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von HLI (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    249087580001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomCypriot167795710001
    ROSS, David Christopher
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United KingdomIrish222326970001
    AUSTIN, Vita Karen
    55 Moorcroft Road
    Hutton
    BS24 9SD Weston Super Mare
    Avon
    Sekretär
    55 Moorcroft Road
    Hutton
    BS24 9SD Weston Super Mare
    Avon
    British68336800002
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Sekretär
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    British117669700002
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    Sekretär
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    221975500001
    OSBORNE, David Anthony
    24 Foye House
    Bridge Road, Leigh Woods
    BS8 3PE Bristol
    Sekretär
    24 Foye House
    Bridge Road, Leigh Woods
    BS8 3PE Bristol
    British70785220001
    OWENS, Jennifer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Sekretär
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    183323150001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Bevollmächtigter Sekretär
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001160001
    BARR, Graham Maxwell
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish125097020001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Geschäftsführer
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritish134140540001
    BRUCE, David James
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish171398800001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritish149939610001
    EGAN, Scott
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritish170703910001
    GILLETT, Martyn Malcolm
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish68329930003
    HAWKESBY, Philip Paul
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritish32278560001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish58444370003
    HOUSE, David Alan Robert
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritish68330030001
    HOYLE, James Shaw
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandEnglish43124960001
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Geschäftsführer
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritish129538180001
    LANSDOWN, Stephen Philip
    Chapters
    Stoke Park Road South
    BS9 1LS Sneyd Park
    Bristol
    Geschäftsführer
    Chapters
    Stoke Park Road South
    BS9 1LS Sneyd Park
    Bristol
    Guernsey, Channel IslandsBritish142340880002
    LYONS, Alastair David
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    EnglandBritish193700420001
    MUGGE, Mark Stephen
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    EnglandBritish162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Gate House
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish113694470002
    REA, Michael Peter
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower Gate House
    Kent
    England
    EnglandBritish147194830001
    SHOTTER, Stephen
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Geschäftsführer
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritish68329810001
    NQH LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001150001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HLI (UK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Portishead Insurance Management Limited
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    06. Apr. 2016
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House Cardiff
    Registrierungsnummer03896351
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat HLI (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Apr. 2015
    Geliefert am 22. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 05. Juli 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 10. Mai 2013
    Geliefert am 23. Mai 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Pursuant to the charge:. The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 29. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security accession deed
    Erstellt am 27. Juni 2012
    Geliefert am 07. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Sept. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2012
    Geliefert am 06. Juli 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 06. Juli 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 23. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 2010
    Geliefert am 18. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 18. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession
    Erstellt am 29. Apr. 2009
    Geliefert am 06. Mai 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 06. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture deed
    Erstellt am 21. Juli 2000
    Geliefert am 27. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat HLI (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Nov. 2018Beginn der Liquidation
    06. Feb. 2020Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0