BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03977289 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Four Brindley Place B1 2HZ Birmingham Westmidlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BERNARD MATTHEWS HOLDINGS LIMITED | 02. Apr. 2001 | 02. Apr. 2001 |
| BERNARD MATTHEWS LIMITED | 22. Feb. 2001 | 22. Feb. 2001 |
| BERNARD MATTHEWS HOLDINGS PLC | 24. Okt. 2000 | 24. Okt. 2000 |
| LEGISLATOR 1473 LIMITED | 20. Apr. 2000 | 20. Apr. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Juni 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 24 Seiten | AM23 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Zaliha Williamson als Geschäftsführer am 30. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Burnett als Geschäftsführer am 30. Juni 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. März 2017 | 20 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 5 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 43 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 44 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Great Witchingham Hall Great Witchingham Norwich NR9 5QD zum Four Brindley Place Birmingham Westmidlands B1 2HZ am 04. Okt. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Yvonne Catherine Mary Goldingham als Sekretär am 18. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2016 bis 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Joll als Geschäftsführer am 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Rae Dalziel Jamieson als Direktor am 29. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 28. Juni 2015 | 38 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 039772890008, erstellt am 28. Aug. 2015 | 81 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall Norwich Norfolk NR9 5QD zum Great Witchingham Hall Great Witchingham Norwich NR9 5QD am 17. Juni 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 29. Juni 2014 | 38 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Burnett als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Zaliha Williamson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMIESON, Alan Rae Dalziel | Geschäftsführer | Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four Westmidlands | England | British | 31138330004 | |||||
| GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary | Sekretär | Great Witchingham NR9 5QD Norwich Great Witchingham Hall England | 172058450001 | |||||||
| GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary | Sekretär | Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | 170469160001 | |||||||
| HARRISON, Neil Charles | Sekretär | Bramley House The Loke Cringleford NR4 6XA Norwich Norfolk | British | 111081410001 | ||||||
| POOLEY, Maureen | Bevollmächtigter Sekretär | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | British | 900008180001 | ||||||
| REGER, David Michael | Sekretär | Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | 171032740001 | |||||||
| REGER, David Michael | Sekretär | Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | British | 151343430001 | ||||||
| AMERIGO, Lee Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 74a Gloucester Street NR2 2DY Norwich | British | 900020250001 | ||||||
| BARTRAM, Noel Frederick | Geschäftsführer | Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | England | British | 37442010003 | |||||
| BURNETT, Robert | Geschäftsführer | Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four Westmidlands | Scotland | British | 86190250002 | |||||
| CLAUSSEN, Carolyn Dawn | Geschäftsführer | Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 107828530001 | |||||
| CROSS, Neil Earl, Doctor | Geschäftsführer | 2 The Heights, Brooklands KT13 0NY Weybridge Surrey | British | 7308500007 | ||||||
| DALLA MURA, Bart Wallace | Geschäftsführer | Epwell Grounds OX15 6HF Banbury Oxfordshire | England | British | 113217530001 | |||||
| ELGERSHUIZEN, George Frederick Bernard | Geschäftsführer | Great Witchingham NR9 5QD Norwich Great Witchingham Hall Norfolk United Kingdom | The Netherlands | Dutch | 160594860001 | |||||
| HARRISON, Neil Charles | Geschäftsführer | Bramley House The Loke Cringleford NR4 6XA Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 111081410001 | |||||
| JOLL, David John | Geschäftsführer | Great Witchingham NR9 5QD Norwich Great Witchingham Hall England | United Kingdom | British | 178372710001 | |||||
| JOLL, David John | Geschäftsführer | Irmingland Hall Corpusty NR11 6QF Holt Norfolk | United Kingdom | British | 178372710001 | |||||
| LUNN, George Michael | Geschäftsführer | Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 194960002 | |||||
| MATTHEWS, Bernard Trevor | Geschäftsführer | Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 10918210001 | |||||
| MATTHEWS, Joyce Kathleen | Geschäftsführer | Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | England | British | 160594930001 | |||||
| MATTHEWS, Joyce Kathleen | Geschäftsführer | Great Witchingham NR9 5QD Norwich Great Witchingham Hall Norfolk United Kingdom | England | British | 160594930001 | |||||
| MCCALL, David Slesser | Geschäftsführer | Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 60326440001 | |||||
| MEARS, Robert Michael | Geschäftsführer | Great Witchingham Hall NR9 5QD Norwich Norfolk England | England | British | 136995510002 | |||||
| NEWTON, David Alexander | Geschäftsführer | Falcon House Mellis IP23 8DS Eye Suffolk | British | 81588700001 | ||||||
| PICKERSGILL, Dominic James | Geschäftsführer | 72 Stafford Street NR2 3BG Norwich Norfolk | British | 60834690001 | ||||||
| POOLEY, Maureen | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 Lodge Lane Old Catton NR6 7HG Norwich Norfolk | British | 900008180001 | ||||||
| SIMPSON, Andrew John | Geschäftsführer | NR9 5QD Norwich Great Witchingham Hall Norfolk England | England | British | 105165150001 | |||||
| WILLIAMSON, Zaliha | Geschäftsführer | Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four Westmidlands | England | British | 323983980001 |
Hat BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 28. Aug. 2015 Geliefert am 03. Sept. 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture creating fixed and floating charges over all the assets and undertakings (present and future) of bernard matthews holdings limited. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Aug. 2013 Geliefert am 05. Sept. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of bernard matthews holdings limited.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of amendment and accession | Erstellt am 20. Jan. 2011 Geliefert am 03. Feb. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due up to a liability of £12,500,000 from the company to bernard matthews pensions fund | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security over cash deposits | Erstellt am 11. Juni 2007 Geliefert am 19. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit in the account presently being £2,054,891. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of debenture | Erstellt am 11. Juni 2007 Geliefert am 21. Juni 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag The first ranking secured liabilities and the second ranking secured liabilities under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Dez. 2006 Geliefert am 15. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 05. Dez. 2006 Geliefert am 08. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 25. Okt. 2000 Geliefert am 13. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all plant and machinery any plant or machinery, charged shares and their related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0