BRIDGEWATER PLACE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBRIDGEWATER PLACE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03978240
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BRIDGEWATER PLACE LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich BRIDGEWATER PLACE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3rd Floor Goodbard House
    15 Infirmary Street
    LS1 2JP Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BRIDGEWATER PLACE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LANDMARK ST JAMES LIMITED19. Juni 200019. Juni 2000
    INHOCO 2065 LIMITED20. Apr. 200020. Apr. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRIDGEWATER PLACE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BRIDGEWATER PLACE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BRIDGEWATER PLACE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 14. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2,000
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 12Th Floor the Basilica 2, King Charles Street Leeds LS1 6LS zum 3Rd Floor Goodbard House 15 Infirmary Street Leeds LS1 2JP am 23. Apr. 2015

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von James Roger Quarmby als Geschäftsführer am 07. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Oliver Alexander Quarmby als Geschäftsführer am 07. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 12. Mai 2014

    • Kapital: GBP 2,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Tonkin als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Tonkin als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. März 2012 bis 29. Sept. 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Level 12 the Basilica 2, King Charles Street Leeds LS1 6LS United Kingdom geändert

    1 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Level 12 the Basilica 2 King Charles Street Leeds West Yorkshire LS1 6LS* am 03. Apr. 2012

    1 SeitenAD01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O St James Securities Limited Fourth Floor, Bridgewater Place Water Lane, Leeds West Yorkshire LS11 5BZ England geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01

    Ernennung von Mr Oliver Alexander Quarmby als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von BRIDGEWATER PLACE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILMAN, Christopher Edward
    3 Court Barton Lane
    Clifford
    LS23 6SN Leeds
    Oak House
    West Yorkshire
    England
    Geschäftsführer
    3 Court Barton Lane
    Clifford
    LS23 6SN Leeds
    Oak House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector79587880005
    MORTON, Kenneth
    Finwood
    College Farm Lane Linton
    LS22 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Finwood
    College Farm Lane Linton
    LS22 4HR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector118089230001
    CORSCADDEN, James Arthur Barrie
    Thimble Hall South Lane
    Cawthorne
    S75 4EE Barnsley
    South Yorkshire
    Sekretär
    Thimble Hall South Lane
    Cawthorne
    S75 4EE Barnsley
    South Yorkshire
    BritishDirector57794320002
    TONKIN, Timothy Patrick
    32 Gledhow Wood Grove
    LS8 1NZ Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    32 Gledhow Wood Grove
    LS8 1NZ Leeds
    West Yorkshire
    British61274100001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    BARRACLOUGH, Ian Firth
    3 Headingley Castle
    Off Headingley Lane
    LS6 2DH Leeds
    Geschäftsführer
    3 Headingley Castle
    Off Headingley Lane
    LS6 2DH Leeds
    EnglandBritishDirector33672260002
    QUARMBY, James Roger
    Arthington Park
    Arthington
    LS21 1PH Otley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Arthington Park
    Arthington
    LS21 1PH Otley
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector3103200002
    QUARMBY, Oliver Alexander
    Floor The Basilica
    2, King Charles Street
    LS1 6LS Leeds
    12th
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor The Basilica
    2, King Charles Street
    LS1 6LS Leeds
    12th
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor80707560005
    TONKIN, Timothy Patrick
    32 Gledhow Wood Grove
    LS8 1NZ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    32 Gledhow Wood Grove
    LS8 1NZ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishSolicitor61274100001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Hat BRIDGEWATER PLACE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Equity account charge
    Erstellt am 01. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit and the account and all rights, benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 01. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Receivable account charge
    Erstellt am 01. März 2004
    Geliefert am 16. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or from any other of the obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit and the account and all rights, benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 17. Okt. 2003
    Geliefert am 05. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The company with full title guarantee hereby assigns to the bank by way of continuing security for the payment and discharge of the secured obligations; the sale contract, the supplemental agreement, the side letter, the advertising hoardings licence;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 2003
    Geliefert am 28. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as or being land on the west side of victoria road, leeds t/n WYK717020.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 2003
    Geliefert am 28. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as or being land on the north side of back row, holbeck, leeds t/n WYK717029.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment
    Erstellt am 10. Okt. 2002
    Geliefert am 14. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest present and future to in and arising out or in respect of the agreement being the licence relating to advertising hoardings at bridgewater place, victoria road/water lane, leeds dated 8 august 2002 made between the company(1) j c decaux united limited(2). By way of assignment the benefit of the agreement and all the company's entitlements to the receipt of all monies from time to time payable. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment by way of security
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 27. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the right title and interest present and future to in and arising out or in respect of the agreement. By way of assignment the benefit of the agreement.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 20. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 20. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land on the west side of victoria road leeds forming part of the land under t/n wyk 411826. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Mai 2002
    Geliefert am 20. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land at back row holbeck leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0