ENGLISH WINES PLC
Überblick
Unternehmensname | ENGLISH WINES PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 03978908 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENGLISH WINES PLC?
- Herstellung von Wein aus Trauben (11020) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich ENGLISH WINES PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Chapel Down Winery Smallhythe Road TN30 7NG Tenterden Kent |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENGLISH WINES PLC?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DOWNLAND WINES PLC | 25. Apr. 2000 | 25. Apr. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENGLISH WINES PLC?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Juni 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ENGLISH WINES PLC?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 25. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 09. Mai 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 25. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENGLISH WINES PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ernennung von Mr James Richard Somerset Pennefather als Direktor am 01. Feb. 2025 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew James Carter als Geschäftsführer am 31. Jan. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 039789080020, erstellt am 18. Sept. 2024 | 77 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 52 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Alexander Bruce Woodhouse als Geschäftsführer am 30. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Allan Charles Smith als Sekretär am 01. Sept. 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Allan Charles Smith als Direktor am 01. Sept. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Alexander Bruce Woodhouse als Sekretär am 31. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Frazer Douglas Thompson als Geschäftsführer am 01. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew James Carter als Direktor am 01. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 9 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 039789080019, erstellt am 08. Juni 2021 | 72 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 039789080018 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Frazer Douglas Thompson am 27. Sept. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Richard Alexander Bruce Woodhouse am 04. Feb. 2021 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Alexander Bruce Woodhouse am 04. Feb. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Frazer Douglas Thompson am 04. Feb. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENGLISH WINES PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMITH, Robert Allan Charles | Sekretär | Chapel Down Winery Smallhythe Road TN30 7NG Tenterden Kent | 299892360001 | |||||||
PENNEFATHER, James Richard Somerset | Geschäftsführer | Chapel Down Winery Smallhythe Road TN30 7NG Tenterden Kent | England | British | Ceo | 296717390001 | ||||
SMITH, Robert Allan Charles | Geschäftsführer | Chapel Down Winery Smallhythe Road TN30 7NG Tenterden Kent | England | British | Cfo | 299636840001 | ||||
BROWN, Christopher Kerr | Sekretär | 19 Woods Green TN5 6QN Wadhurst East Sussex | British | 61828640001 | ||||||
CAST, Samantha May | Sekretär | Dial House East Street Harrietsham ME17 1HJ Maidstone Kent | British | Accountant | 62318220001 | |||||
SCHUPKE, Sally Ann | Sekretär | 5 Magazine Cottages Old Manor Lane Chilworth GU4 8NE Guildford Surrey | British | Trade Mark Agent | 4712710001 | |||||
WOODHOUSE, Richard Alexander Bruce | Sekretär | Chapel Down Winery Smallhythe Road TN30 7NG Tenterden Kent | British | Chartered Accountant | 127329770001 | |||||
BRANCH, Nicholas Michael | Geschäftsführer | Wivelrod Farmhouse Wivelrod GU34 4AS Alton Hampshire | British | Consultant | 35544290002 | |||||
BRETT, Paul | Geschäftsführer | 2 Brookside Road NW11 9NE London | United Kingdom | British | Director | 68902240001 | ||||
BROWN, Christopher Kerr | Geschäftsführer | The Vines Lamberhurst Vineyard TN3 8ER Lamberhurst Kent | England | British | Accountant | 61828640007 | ||||
CARTER, Andrew James | Geschäftsführer | Chapel Down Winery Smallhythe Road TN30 7NG Tenterden Kent | United Kingdom | British | Chief Executive | 207996650001 | ||||
DREWE, Adrian Peter | Geschäftsführer | Parsonage Farm TN5 7DL Ticehurst East Sussex | United Kingdom | British | Director | 56778850001 | ||||
HAZELL, Timothy Robert Brian | Geschäftsführer | Kirurumu 4 Ridgemount Way RH1 6JT Redhill Surrey | British | Wine Consultant | 77489100001 | |||||
HAZELL, Timothy Robert Brian | Geschäftsführer | Kirurumu 4 Ridgemount Way RH1 6JT Redhill Surrey | British | Consultant | 77489100001 | |||||
HUME KENDALL, Simon Patrick | Geschäftsführer | The Oast House Lamberhurst Vineyard TN3 8ER Lamberhurst Kent | Kent | British | Director | 107579300001 | ||||
PILCHER, Anthony David | Geschäftsführer | 8a Victoria Road Kensington W8 5RD London | United Kingdom | British | Viticulturist | 5558490001 | ||||
SCHUPKE, Sally Ann | Geschäftsführer | 5 Magazine Cottages Old Manor Lane Chilworth GU4 8NE Guildford Surrey | British | Trade Mark Agent | 4712710001 | |||||
THOMPSON, Frazer Douglas | Geschäftsführer | Chapel Down Winery Smallhythe Road TN30 7NG Tenterden Kent | England | English | Managing Director | 81297490004 | ||||
WOODHOUSE, Richard Alexander Bruce | Geschäftsführer | Chapel Down Winery Smallhythe Road TN30 7NG Tenterden Kent | England | British | Chartered Accountant | 127329770001 | ||||
INTERMARK (GUILDFORD) LIMITED | Geschäftsführer | 40a Castle Street GU1 3UQ Guildford Surrey | 34564750001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENGLISH WINES PLC?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chapel Down Group Plc | 06. Apr. 2016 | Small Hythe Road Small Hythe TN30 7NG Tenterden Chapel Down Winery Kent England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ENGLISH WINES PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 18. Sept. 2024 Geliefert am 27. Sept. 2024 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Property including the leasehold property at champion court farm, sharsted hill, newnham, sittingbourne ME9 0JX and registered with title number TT66226. For further details please refer to the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Juni 2021 Geliefert am 15. Juni 2021 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung A leasehold property at champion court farm, sharsted hill, newnham, sittingbourne ME9 0JX, within the administrative area of swale and title number: TT66226.. Various intellectual property, including a registered trade mark with bwt case reference of T103343GB00, official number of 2499858, country of united kingdom, case category: normal, title/mark as chapel and device (series of 2), classes (local) as 33, filing date as 10/10/2008, registration date of 30/01/2009 and a next renewal date of 10/10/2028. further intellectual property is particularised in schedule 2, part 4A to part 4D. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 09. Jan. 2017 Geliefert am 10. Jan. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung A fixed and floating charge over all assets. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 30. Sept. 2008 Geliefert am 03. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £225,126.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Hansens stainless steel wall bench. Rubbermaid slim jim waste bin. Williams 3 door refrigerated counter with door and 2 bays of three drawers (for details of further goods charged please refer to the form 395) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 22. Dez. 2003 Geliefert am 02. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £203,510.71 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The items listed on the attached schedule to form 395 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books, manuals, handbooks, technical data, drawings, schedules and other documentation (or any amendments to them) belonging to the above items.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 12. Nov. 2002 Geliefert am 15. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000.00 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (I)steel wine tank,model CT1A,ref 200-4,capacity of 20,000 litres located in tenterden; (ii) steel wine tank,model CT1A,ref 200-05,capacity of 20,000 litres located in tenterden; (iii) steel wine tank,model CT1A,ref 200-06,capacity of 20,000 litres located in tenterden with all accessories and component parts,all improvements and renewals thereof together with all books,manuals,handbooks,technical data,drawings,schedules and other documentation; see form 395 for details of further chattels charged. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage over winestock | Erstellt am 24. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed legal mortgage over all present winestock.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Apr. 2002 Geliefert am 30. Apr. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Juni 2001 Geliefert am 14. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a tenterden vineyard park small hythe tenterden kent t/n K452071. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Mai 2001 Geliefert am 23. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage over winestock | Erstellt am 10. Mai 2001 Geliefert am 16. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Each part and all of the winestock of the company as specified in the schedule to the winestock mortgage and the benefit of all insurance, the proceeds of all book debts and a floating charge over the winestock and the proceeds of sale and insurance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 04. Mai 2001 Geliefert am 10. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The items as listed on the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage over wine stock | Erstellt am 23. Nov. 2000 Geliefert am 08. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 23RD november 2000 | |
Kurze Angaben By way of fixed legal mortgage, all the wine stock of the company now vested in it wherever it may be stored, all fixed charges of the wine stock, the full benefit of all insurance from time to time in force in relation to the wine stock, by way of floating charge all interests. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of chattel mortgage | Erstellt am 23. Nov. 2000 Geliefert am 08. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 23RD november 2000 | |
Kurze Angaben The plant, equipment and chattels, including all appliances parts spare parts components instruments appurtenances accessories and other equipment of any kind installed therein or thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Nov. 2000 Geliefert am 08. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 23RD november 2000 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage over wine stock | Erstellt am 23. Nov. 2000 Geliefert am 08. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with a loan agreement of even date together with all cost and expenses | |
Kurze Angaben All the wine stock of the company now vested in it wherever it may be stored all fixed charges of the wine stock hereafter belonging to the company the benefit of all insurance from time to time in relation to the wine. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of chattel mortgage | Erstellt am 23. Nov. 2000 Geliefert am 08. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with a loan agreement of even date together with all costs and expenses | |
Kurze Angaben The plant equipment and chattles specified in the schedule annexed to the deed of chattle mortgage and all log books maintenance records record books manuals etc relating to the chattles. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Nov. 2000 Geliefert am 08. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursaunt to a loan agreement of even date together with all costs and expenses | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 21. Nov. 2000 Geliefert am 30. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Vessel 250-1 product emt vllage 25,000, 250-2 product ba litres 25,000 style w, 250-3 product emt vllage 25,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Sept. 2000 Geliefert am 07. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0