ENGLISH WINES PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameENGLISH WINES PLC
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03978908
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ENGLISH WINES PLC?

    • Herstellung von Wein aus Trauben (11020) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich ENGLISH WINES PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ENGLISH WINES PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DOWNLAND WINES PLC25. Apr. 200025. Apr. 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENGLISH WINES PLC?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Juni 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ENGLISH WINES PLC?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis25. Apr. 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung09. Mai 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis25. Apr. 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für ENGLISH WINES PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Ernennung von Mr James Richard Somerset Pennefather als Direktor am 01. Feb. 2025

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Andrew James Carter als Geschäftsführer am 31. Jan. 2025

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 039789080020, erstellt am 18. Sept. 2024

    77 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023

    52 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    28 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Richard Alexander Bruce Woodhouse als Geschäftsführer am 30. Aug. 2022

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Robert Allan Charles Smith als Sekretär am 01. Sept. 2022

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Robert Allan Charles Smith als Direktor am 01. Sept. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Richard Alexander Bruce Woodhouse als Sekretär am 31. Aug. 2022

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Frazer Douglas Thompson als Geschäftsführer am 01. Okt. 2021

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Andrew James Carter als Direktor am 01. Okt. 2021

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    26 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    9 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Eintragung der Belastung 039789080019, erstellt am 08. Juni 2021

    72 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 039789080018 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Frazer Douglas Thompson am 27. Sept. 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Richard Alexander Bruce Woodhouse am 04. Feb. 2021

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Richard Alexander Bruce Woodhouse am 04. Feb. 2021

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Frazer Douglas Thompson am 04. Feb. 2021

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von ENGLISH WINES PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMITH, Robert Allan Charles
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    Sekretär
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    299892360001
    PENNEFATHER, James Richard Somerset
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    Geschäftsführer
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    EnglandBritishCeo296717390001
    SMITH, Robert Allan Charles
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    Geschäftsführer
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    EnglandBritishCfo299636840001
    BROWN, Christopher Kerr
    19
    Woods Green
    TN5 6QN Wadhurst
    East Sussex
    Sekretär
    19
    Woods Green
    TN5 6QN Wadhurst
    East Sussex
    British61828640001
    CAST, Samantha May
    Dial House
    East Street Harrietsham
    ME17 1HJ Maidstone
    Kent
    Sekretär
    Dial House
    East Street Harrietsham
    ME17 1HJ Maidstone
    Kent
    BritishAccountant62318220001
    SCHUPKE, Sally Ann
    5 Magazine Cottages Old Manor Lane
    Chilworth
    GU4 8NE Guildford
    Surrey
    Sekretär
    5 Magazine Cottages Old Manor Lane
    Chilworth
    GU4 8NE Guildford
    Surrey
    BritishTrade Mark Agent4712710001
    WOODHOUSE, Richard Alexander Bruce
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    Sekretär
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    BritishChartered Accountant127329770001
    BRANCH, Nicholas Michael
    Wivelrod Farmhouse
    Wivelrod
    GU34 4AS Alton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Wivelrod Farmhouse
    Wivelrod
    GU34 4AS Alton
    Hampshire
    BritishConsultant35544290002
    BRETT, Paul
    2 Brookside Road
    NW11 9NE London
    Geschäftsführer
    2 Brookside Road
    NW11 9NE London
    United KingdomBritishDirector68902240001
    BROWN, Christopher Kerr
    The Vines
    Lamberhurst Vineyard
    TN3 8ER Lamberhurst
    Kent
    Geschäftsführer
    The Vines
    Lamberhurst Vineyard
    TN3 8ER Lamberhurst
    Kent
    EnglandBritishAccountant61828640007
    CARTER, Andrew James
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    Geschäftsführer
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    United KingdomBritishChief Executive207996650001
    DREWE, Adrian Peter
    Parsonage Farm
    TN5 7DL Ticehurst
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Parsonage Farm
    TN5 7DL Ticehurst
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector56778850001
    HAZELL, Timothy Robert Brian
    Kirurumu
    4 Ridgemount Way
    RH1 6JT Redhill
    Surrey
    Geschäftsführer
    Kirurumu
    4 Ridgemount Way
    RH1 6JT Redhill
    Surrey
    BritishWine Consultant77489100001
    HAZELL, Timothy Robert Brian
    Kirurumu
    4 Ridgemount Way
    RH1 6JT Redhill
    Surrey
    Geschäftsführer
    Kirurumu
    4 Ridgemount Way
    RH1 6JT Redhill
    Surrey
    BritishConsultant77489100001
    HUME KENDALL, Simon Patrick
    The Oast House
    Lamberhurst Vineyard
    TN3 8ER Lamberhurst
    Kent
    Geschäftsführer
    The Oast House
    Lamberhurst Vineyard
    TN3 8ER Lamberhurst
    Kent
    KentBritishDirector107579300001
    PILCHER, Anthony David
    8a Victoria Road
    Kensington
    W8 5RD London
    Geschäftsführer
    8a Victoria Road
    Kensington
    W8 5RD London
    United KingdomBritishViticulturist5558490001
    SCHUPKE, Sally Ann
    5 Magazine Cottages Old Manor Lane
    Chilworth
    GU4 8NE Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    5 Magazine Cottages Old Manor Lane
    Chilworth
    GU4 8NE Guildford
    Surrey
    BritishTrade Mark Agent4712710001
    THOMPSON, Frazer Douglas
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    Geschäftsführer
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    EnglandEnglishManaging Director81297490004
    WOODHOUSE, Richard Alexander Bruce
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    Geschäftsführer
    Chapel Down Winery
    Smallhythe Road
    TN30 7NG Tenterden
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant127329770001
    INTERMARK (GUILDFORD) LIMITED
    40a Castle Street
    GU1 3UQ Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    40a Castle Street
    GU1 3UQ Guildford
    Surrey
    34564750001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENGLISH WINES PLC?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Chapel Down Group Plc
    Small Hythe Road
    Small Hythe
    TN30 7NG Tenterden
    Chapel Down Winery
    Kent
    England
    06. Apr. 2016
    Small Hythe Road
    Small Hythe
    TN30 7NG Tenterden
    Chapel Down Winery
    Kent
    England
    Nein
    RechtsformCompany
    RechtsgrundlageUk Company Law
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat ENGLISH WINES PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 18. Sept. 2024
    Geliefert am 27. Sept. 2024
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Property including the leasehold property at champion court farm, sharsted hill, newnham, sittingbourne ME9 0JX and registered with title number TT66226. For further details please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2024Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Juni 2021
    Geliefert am 15. Juni 2021
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    A leasehold property at champion court farm, sharsted hill, newnham, sittingbourne ME9 0JX, within the administrative area of swale and title number: TT66226.. Various intellectual property, including a registered trade mark with bwt case reference of T103343GB00, official number of 2499858, country of united kingdom, case category: normal, title/mark as chapel and device (series of 2), classes (local) as 33, filing date as 10/10/2008, registration date of 30/01/2009 and a next renewal date of 10/10/2028. further intellectual property is particularised in schedule 2, part 4A to part 4D.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD
    Transaktionen
    • 15. Juni 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 09. Jan. 2017
    Geliefert am 10. Jan. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    A fixed and floating charge over all assets.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 08. Juni 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 2008
    Geliefert am 03. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £225,126.13 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Hansens stainless steel wall bench. Rubbermaid slim jim waste bin. Williams 3 door refrigerated counter with door and 2 bays of three drawers (for details of further goods charged please refer to the form 395) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Dez. 2003
    Geliefert am 02. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £203,510.71 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The items listed on the attached schedule to form 395 together with all accessories and component parts and all improvements and renewals thereof together also with all books, manuals, handbooks, technical data, drawings, schedules and other documentation (or any amendments to them) belonging to the above items.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 12. Nov. 2002
    Geliefert am 15. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000.00 and all other sums due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (I)steel wine tank,model CT1A,ref 200-4,capacity of 20,000 litres located in tenterden; (ii) steel wine tank,model CT1A,ref 200-05,capacity of 20,000 litres located in tenterden; (iii) steel wine tank,model CT1A,ref 200-06,capacity of 20,000 litres located in tenterden with all accessories and component parts,all improvements and renewals thereof together with all books,manuals,handbooks,technical data,drawings,schedules and other documentation; see form 395 for details of further chattels charged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage over winestock
    Erstellt am 24. Apr. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed legal mortgage over all present winestock.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • English Wines Group PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Apr. 2002
    Geliefert am 30. Apr. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • English Wines Group PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juni 2001
    Geliefert am 14. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a tenterden vineyard park small hythe tenterden kent t/n K452071.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 16. Mai 2001
    Geliefert am 23. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage over winestock
    Erstellt am 10. Mai 2001
    Geliefert am 16. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Each part and all of the winestock of the company as specified in the schedule to the winestock mortgage and the benefit of all insurance, the proceeds of all book debts and a floating charge over the winestock and the proceeds of sale and insurance.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 04. Mai 2001
    Geliefert am 10. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £150,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The items as listed on the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage over wine stock
    Erstellt am 23. Nov. 2000
    Geliefert am 08. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 23RD november 2000
    Kurze Angaben
    By way of fixed legal mortgage, all the wine stock of the company now vested in it wherever it may be stored, all fixed charges of the wine stock, the full benefit of all insurance from time to time in force in relation to the wine stock, by way of floating charge all interests. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Brett
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of chattel mortgage
    Erstellt am 23. Nov. 2000
    Geliefert am 08. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 23RD november 2000
    Kurze Angaben
    The plant, equipment and chattels, including all appliances parts spare parts components instruments appurtenances accessories and other equipment of any kind installed therein or thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Brett
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Nov. 2000
    Geliefert am 08. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 23RD november 2000
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Paul Brett
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage over wine stock
    Erstellt am 23. Nov. 2000
    Geliefert am 08. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with a loan agreement of even date together with all cost and expenses
    Kurze Angaben
    All the wine stock of the company now vested in it wherever it may be stored all fixed charges of the wine stock hereafter belonging to the company the benefit of all insurance from time to time in relation to the wine. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lamberhurst Vineyards (2000) Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of chattel mortgage
    Erstellt am 23. Nov. 2000
    Geliefert am 08. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with a loan agreement of even date together with all costs and expenses
    Kurze Angaben
    The plant equipment and chattles specified in the schedule annexed to the deed of chattle mortgage and all log books maintenance records record books manuals etc relating to the chattles. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lamberhurst Vineyards (2000) Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Nov. 2000
    Geliefert am 08. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursaunt to a loan agreement of even date together with all costs and expenses
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lamberhurst Vineyards (2000) Limited
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 21. Nov. 2000
    Geliefert am 30. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Vessel 250-1 product emt vllage 25,000, 250-2 product ba litres 25,000 style w, 250-3 product emt vllage 25,000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Sept. 2000
    Geliefert am 07. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0