HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 03981892 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| JAMES HARVARD FINANCIAL LIMITED | 10. Feb. 2004 | 10. Feb. 2004 |
| JAMES HARVARD INTERNATIONAL LIMITED | 27. Apr. 2000 | 27. Apr. 2000 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Apr. 2019 | 32 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 32 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 250 Euston Road London NW1 2AF zum 55 Baker Street London W1U 7EU am 25. Juni 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Venables als Geschäftsführer am 11. Mai 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr John Harrington als Direktor am 28. Jan. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Ian Stamper als Geschäftsführer am 28. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAYS NOMINEES LIMITED | Sekretär | 250 Euston Road NW1 2AF London |
| 100317500002 | ||||||||||
| HARRINGTON, John | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | 204721550001 | |||||||||
| BORT, Stefan Edward | Sekretär | 250 Euston Road NW1 2AF London | British | 32824200011 | ||||||||||
| BROADFOOT, Victoria | Sekretär | 8 Glencoe Mansions Mowl Street SW9 0ER London | British | 90446930001 | ||||||||||
| MURTON, Sonia | Sekretär | Bartley Mill Cottage Bartley Mill Road Little Bayham TN3 8BH Lamberhurst East Sussex | British | 46039000004 | ||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
| BEEKE, Paul | Geschäftsführer | Unit 623 21 Wormwood Street Boston Ma 002210 Usa | British | 77548950003 | ||||||||||
| BROADFOOT, Victoria | Geschäftsführer | 8 Glencoe Mansions Mowl Street SW9 0ER London | British | 90446930001 | ||||||||||
| DUQUENOY, Philip James | Geschäftsführer | 250 Euston Road London NW1 2AF | England | British | 96824460001 | |||||||||
| DUQUENOY, Philip James | Geschäftsführer | 71 Bray Road GU2 7LJ Guildford Surrey | England | British | 96824460001 | |||||||||
| HOLMES, Mark Walter James | Geschäftsführer | 57a Cobden Road TN13 3UB Sevenoaks Kent | British | 70286390001 | ||||||||||
| JACKSON, Richard | Geschäftsführer | Euston Road NW1 2AF London 250 | United Kingdom | British | 120037780002 | |||||||||
| KEBBELL, Nicholas | Geschäftsführer | North Cottage Langton Road Langton Green TN3 0BB Tunbridge Wells Kent | British | 84097270001 | ||||||||||
| MCRAE, Andrew James | Geschäftsführer | Euston Road NW1 2AF London 250 | British | 2890800005 | ||||||||||
| MURTON, Andrew David | Geschäftsführer | Bartley Mill Cottage Little Bayham TN3 8BH Lamberhurst East Sussex | British | 73121540001 | ||||||||||
| ROGERS, Stewart James | Geschäftsführer | White Lodge 3 Southlea Road SL3 9BY Datchet Berkshire | United Kingdom | British | 57367070001 | |||||||||
| SCHIEMER, Bernard Keith | Geschäftsführer | Flat 3 19 Broadwater Down TN2 5NJ Tunbridge Wells Kent | Austrailian | 70286340002 | ||||||||||
| STAMPER, Christopher Ian | Geschäftsführer | 250 Euston Road London NW1 2AF | England | British | 154777820001 | |||||||||
| VENABLES, Paul | Geschäftsführer | Euston Road NW1 2AF London 250 | United Kingdom | British | 103911420006 | |||||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harvard International Group Limited | 06. Apr. 2016 | Euston Road NW1 2AF London 250 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Nov. 2005 Geliefert am 10. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any group company to the chargee or to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Aug. 2005 Geliefert am 23. Aug. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. März 2004 Geliefert am 31. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 22. Sept. 2003 Geliefert am 25. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £8,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The sum of £8,500 plus an amount equivalent to vat thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 27. Apr. 2001 Geliefert am 09. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee ("the security holder") in accordance with the terms of the transaction, security, instrument or other obligation including those under the financing agreement (all terms as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 04. Aug. 2000 Geliefert am 19. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the lease | |
Kurze Angaben All sums from time to time constituting the security deposit and any additional sums paid into the deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge on book debts | Erstellt am 03. Aug. 2000 Geliefert am 04. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement dated 12TH july 2000 (as therein defined) or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed charge all specified debts being any book debts (purchased or purported to be purchased by the chargee pursuant to the agreement) the ownership of which fail to vest in the chargee for any reason together with the related rights pertaining to such book debts, all other debts being all amounts of indebtedness now or at any time owing to the company on any account whatsoever (together with the related rights) other than specified debts, floating charge such moneys which the company may receive in respect of the other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HAYS FINANCE TECHNOLOGY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0