CELLTRAN LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCELLTRAN LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 03990521
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CELLTRAN LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich CELLTRAN LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pannell House
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CELLTRAN LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für CELLTRAN LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Änderung der Details des Direktors für David Livesley am 01. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    11 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 29. Nov. 2008

    8 Seiten2.24B

    Vorschlag des Verwalters

    39 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    15 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    11 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2007

    19 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2006

    16 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    8 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von CELLTRAN LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BIRTLES, Richard Mark
    Daleside Cottage
    The Dale
    S32 5QU Eyam
    Derbyshire
    Sekretär
    Daleside Cottage
    The Dale
    S32 5QU Eyam
    Derbyshire
    BritishDirector11874580003
    BAYNES, David Graham
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    The Lodge Station Road
    Haddenham
    CB6 3XD Ely
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishDirector177146390001
    GRANT, Peter Leonard, Dr
    Harlequin Old Hurst Road
    Pidley
    PE17 3BY Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Harlequin Old Hurst Road
    Pidley
    PE17 3BY Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishConsultant35071850004
    HADDOW, David Bryan, Dr
    63 Stewart Road
    S11 8XS Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    63 Stewart Road
    S11 8XS Sheffield
    South Yorkshire
    BritishOperations Director99186440001
    JARMOLOWICZ, Malgosia
    24 Philip Godlee Lodge
    842 Wilmslow Road
    M20 2DS Didsbury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    24 Philip Godlee Lodge
    842 Wilmslow Road
    M20 2DS Didsbury
    Lancashire
    EnglandBritishCeo85071080001
    LIVESLEY, David John
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    Pannell House
    Geschäftsführer
    6 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    Pannell House
    EnglandBritishFund Manager120541080001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ARMITAGE, Peter Robert
    Coach House
    Sycamore Lane Springwood Road
    HD7 2SJ Holmfirth
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Coach House
    Sycamore Lane Springwood Road
    HD7 2SJ Holmfirth
    West Yorkshire
    BritishInvestment Manager107266580001
    ASH, Charles Bruce
    7 Penwortham Court
    Penwortham
    PR1 9YX Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Penwortham Court
    Penwortham
    PR1 9YX Preston
    Lancashire
    EnglandBritishManaging Director87833550001
    BEANLAND, Geoffrey David
    The Old Store
    Frieth
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Old Store
    Frieth
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    UkBritishConsultant57551590001
    CATTON, David John, Mr.
    The Old Hall Farm
    Main Road
    S42 7AJ Cutthorpe Chesterfield
    Geschäftsführer
    The Old Hall Farm
    Main Road
    S42 7AJ Cutthorpe Chesterfield
    EnglandBritishDirector61207660003
    GOSTICK, Nicholas Andrew, Dr
    815 Upper Wortley Road
    Thorpe Hesley
    S61 2PN Rotherham
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    815 Upper Wortley Road
    Thorpe Hesley
    S61 2PN Rotherham
    South Yorkshire
    BritishTech Manager59606400001
    HILL PERKINS, Michele Susanne, Dr
    22 Irving Road
    W14 0JS London
    Geschäftsführer
    22 Irving Road
    W14 0JS London
    BritishProject Director107266650001
    HIMAN, Harry
    18 Alexandra Gardens
    S11 9DQ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    18 Alexandra Gardens
    S11 9DQ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director124814010001
    MACNEIL, Sheila, Prof
    38 Meadowbank Avenue
    S7 1PB Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    38 Meadowbank Avenue
    S7 1PB Sheffield
    South Yorkshire
    BritishReader19668530001
    MATTON, Christian
    Fosselstraat 48
    Affligem
    B-1790
    Belgium
    Geschäftsführer
    Fosselstraat 48
    Affligem
    B-1790
    Belgium
    BelgianVice President Legal And Ip M116516110001
    MORICH, Frank Joachim Robert
    Unter Den Ulmen 1b
    FOREIGN Cologne
    50968
    Germany
    Geschäftsführer
    Unter Den Ulmen 1b
    FOREIGN Cologne
    50968
    Germany
    GermanCeo Managing Director116516190001
    SHORT, Robert David, Professor
    1 Oakholme Mews
    S10 3FX Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Oakholme Mews
    S10 3FX Sheffield
    South Yorkshire
    BritishUniversity Academic70925850001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Hat CELLTRAN LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 21. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital and equipment,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yfm Venture Finance Limited
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 20. Apr. 2006
    Geliefert am 08. Mai 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Wellcome Trust Limited
    Transaktionen
    • 08. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Aug. 2005
    Geliefert am 13. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the stockholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yfm Venture Finance Limited Acting as Agent and Security Trustee for the Loan Stock Holders
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Nov. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 13. Jan. 2005
    Geliefert am 19. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property to include inventions : detatchments surface, country: pct, australia, new zealand, south afric, number wo 00/786839, AU776839, NZ516064 and ZA200110319, effective filing date :23 june 2000, date granted: 28 december 2000. invention: vehicle, country pct, number WO02-083176, effective filing date:17 april 2002, date granted : 24 october 2002. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire and Humber Regional Venture Capital Fund No.1 L.P
    Transaktionen
    • 19. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Nov. 2006Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)

    Hat CELLTRAN LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Mai 2009Ende der Verwaltung
    30. Mai 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles William Anthony Escott
    Regent House Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Regent House Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    William Duncan
    Pkf (Uk) Llp
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    Praktiker
    Pkf (Uk) Llp
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    2
    DatumTyp
    08. Juli 2011Aufgelöst am
    29. Mai 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Charles William Anthony Escott
    Regent House Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Regent House Clinton Avenue
    NG5 1AZ Nottingham
    Nottinghamshire
    William Duncan
    Unit 1 Calder Close
    Calder Park
    WF4 3BA Wakefield
    West Yorkshire
    Praktiker
    Unit 1 Calder Close
    Calder Park
    WF4 3BA Wakefield
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0