YOUR SPACE PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameYOUR SPACE PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 03995171
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von YOUR SPACE PLC?

    • (7011) /
    • (7012) /
    • (7020) /
    • (7032) /

    Wo befindet sich YOUR SPACE PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von YOUR SPACE PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TECHNOLOGY AND INTERNET PROPERTY SERVICES PLC11. Mai 200011. Mai 2000

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von YOUR SPACE PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2008

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für YOUR SPACE PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für YOUR SPACE PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    5 SeitenDS01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. März 2013

    21 Seiten2.24B

    Mitteilung über einen Gerichtsbeschluss zur Beendigung der Verwaltung

    21 Seiten2.33B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Sept. 2012

    23 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. März 2012

    23 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Sept. 2011

    22 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. März 2011

    22 Seiten2.24B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 12. Apr. 2011

    2 Seiten1.3

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 15. Nov. 2010

    3 Seiten1.3

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Sept. 2010

    20 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    17 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    57 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    57 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 City Square Leeds West Yorkshire LS1 2AL am 29. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 23 New Mount Street Manchester Lancashire M4 4DE am 22. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    Seiten1.1

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Ernennung von Stephen Turton als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Sue Lace als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Raymond Harris als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von YOUR SPACE PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TURTON, Stephen
    Water Street
    L2 0RD Liverpool
    7
    Merseyside
    Sekretär
    Water Street
    L2 0RD Liverpool
    7
    Merseyside
    British148794230001
    DAVIS, Laurence Howard
    18 Westbourne Terrace
    W2 3UP London
    Geschäftsführer
    18 Westbourne Terrace
    W2 3UP London
    EnglandBritishCompany Director41379070001
    MEALEY, Shaun
    Lower Hall Farm
    Sugar Lane Manley
    WA6 9HW Frodsham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Lower Hall Farm
    Sugar Lane Manley
    WA6 9HW Frodsham
    Cheshire
    EnglandBritishDirector75263470001
    MILLAR, Seamus Joseph
    5 Stainforth Close
    WA3 4HZ Culcheth
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Stainforth Close
    WA3 4HZ Culcheth
    Cheshire
    United KingdomBritishCo Director75263350001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    Geschäftsführer
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritishDirector46176700002
    TURTON, Stephen Mark
    2 Cavan Drive
    WA11 0GN St Helens
    Geschäftsführer
    2 Cavan Drive
    WA11 0GN St Helens
    United KingdomBritishDirector112981880001
    GARNHAM, Vanessa Indira
    Le Formentor,
    27 Avenue Princesse Grace
    FOREIGN Monaco
    Mc 98000
    Sekretär
    Le Formentor,
    27 Avenue Princesse Grace
    FOREIGN Monaco
    Mc 98000
    BritishChartered Secretary30058370006
    HARRIS, Raymond Ian
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    Sekretär
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    British91547170001
    LACE, Sue
    41 Lowden Avenue
    L21 9JE Litherland
    Sekretär
    41 Lowden Avenue
    L21 9JE Litherland
    British116594600001
    MILLAR, Seamus Joseph
    5 Stainforth Close
    WA3 4HZ Culcheth
    Cheshire
    Sekretär
    5 Stainforth Close
    WA3 4HZ Culcheth
    Cheshire
    BritishDirector75263350001
    ROTHBARTH, Lynda Mary
    Peppard Cottage
    Peppard Common
    RG9 5LB Henley On Thames
    Oxfordshire
    Sekretär
    Peppard Cottage
    Peppard Common
    RG9 5LB Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishAccountant17187570002
    TIDBALL, Christopher Nelson
    52 Oakwood Avenue
    BR3 6PJ Beckenham
    Kent
    Sekretär
    52 Oakwood Avenue
    BR3 6PJ Beckenham
    Kent
    BritishAccountant252625970001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BEVAN, Anita Maria
    Tanners Plat
    Mill Road
    TN36 4HT Winchelsea
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Tanners Plat
    Mill Road
    TN36 4HT Winchelsea
    East Sussex
    EnglandBritishDirector Of Operations76857840001
    FELLOWES, James Henry Edward
    2a Campden Hill Court
    W8 7HX London
    Geschäftsführer
    2a Campden Hill Court
    W8 7HX London
    United KingdomBritishConsultant39588330002
    HARRIS, Raymond Ian
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    Geschäftsführer
    3 Golfside Close
    N20 0RD London
    United KingdomBritishChartered Accountant91547170001
    ILSLEY, Ian
    57 Rue Grimaldi
    Monte Carlo
    Mc 98000
    Monaco
    Geschäftsführer
    57 Rue Grimaldi
    Monte Carlo
    Mc 98000
    Monaco
    MonacoBritishDirector3548270001
    MARRACHE, Abraham Samuel
    Fortress House
    9 Cathedral Square
    FOREIGN Gibraltar
    Geschäftsführer
    Fortress House
    9 Cathedral Square
    FOREIGN Gibraltar
    GibraltarBritishFinancier147331360001
    SONING, Harvey Murray
    72/75 Marylebone High Street
    W1M 3AR London
    Geschäftsführer
    72/75 Marylebone High Street
    W1M 3AR London
    United KingdomBritishProperty Consultant267082750001
    TIDBALL, Christopher Nelson
    52 Oakwood Avenue
    BR3 6PJ Beckenham
    Kent
    Geschäftsführer
    52 Oakwood Avenue
    BR3 6PJ Beckenham
    Kent
    EnglandBritishAccountant252625970001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    Hat YOUR SPACE PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 2007
    Geliefert am 05. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H head post office, fitzalan square, sheffield t/no SYK465182 investments, pla. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ya Global Investments L.P.
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Sept. 2007
    Geliefert am 05. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H head post office fitzalan square sheffield t/no SYK465182 all present and future estates. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Willenhall Limited
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 26. Sept. 2007
    Geliefert am 05. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £365,000.00 and all monies from time to time standing to the credit of a designated high interest earning deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Workspace (North West) Limited
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 12. Sept. 2007
    Geliefert am 15. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £515,000.00 and all monies from time to time standing to the credit of a designated interest earning deposit account opened by on or behalf of the landlord pursuant to the rent deposit deed.
    Berechtigte Personen
    • Capital Hatton Limited
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Mai 2007
    Geliefert am 12. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £359,400.00 standing to the credit of a designated interest earning deposit account.
    Berechtigte Personen
    • Capital Liverpool Limited
    Transaktionen
    • 12. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Mai 2007
    Geliefert am 24. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property being head post office fitzalan square sheffield t/n SYK465182,. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 24. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19/06/07 and
    Erstellt am 16. Mai 2007
    Geliefert am 23. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    24 st vincent place glasgow t/no GLA194461.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 23. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 05. Sept. 2006
    Geliefert am 15. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due amounting to £493,500 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Its interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Workspace (North West) Limited
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Aug. 2006
    Geliefert am 18. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property being 7 water street and 3 fenwick street liverpool t/n MS105418. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Juni 2006
    Geliefert am 17. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H heywoods building 5 brunswick street liverpool. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 17. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 13. Apr. 2006
    Geliefert am 22. Apr. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £441,176.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from it.
    Berechtigte Personen
    • Your Space Clerkenwell Limited
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge on deposit
    Erstellt am 26. Jan. 2006
    Geliefert am 08. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge the deposit and all entitlements to interest.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 26. Jan. 2006
    Geliefert am 08. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of deposit
    Erstellt am 26. Feb. 2002
    Geliefert am 01. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit initially of £790,384 credited to account designation 10153718 with the bank and any addition to that deposit.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat YOUR SPACE PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Nov. 2009Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    26. März 2010Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    William Kenneth Dawson
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    2
    DatumTyp
    26. März 2010Beginn der Verwaltung
    22. März 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    William Kenneth Dawson
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    2 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0