FOSTERING SOLUTIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFOSTERING SOLUTIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04006225
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FOSTERING SOLUTIONS LIMITED?

    • Sonstige soziale Arbeit ohne Unterbringung n.n.g. (88990) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich FOSTERING SOLUTIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Atria
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOSTERING SOLUTIONS LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Aug. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Mai 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für FOSTERING SOLUTIONS LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis01. Juni 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung15. Juni 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis01. Juni 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für FOSTERING SOLUTIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Ernennung von Mr Simon Timothy Barclay als Direktor am 01. März 2025

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Aug. 2023

    24 SeitenAA

    legacy

    60 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Eintragung der Belastung 040062250016, erstellt am 08. Feb. 2024

    43 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 040062250015 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von David Jon Leatherbarrow als Geschäftsführer am 23. Nov. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jean-Luc Emmanuel Janet als Geschäftsführer am 23. Nov. 2023

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Jon Leatherbarrow am 19. Juni 2023

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2022

    29 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mrs Lynn Mary Webb als Direktor am 11. März 2023

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Alison Bennett als Sekretär am 15. Dez. 2022

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Ryan David Edwards als Direktor am 15. Dez. 2022

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Richard John Cooke als Geschäftsführer am 15. Dez. 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Chris Duffy als Sekretär am 15. Dez. 2022

    1 SeitenTM02

    Notification of Belton Associates Limited as a person with significant control on 23. Nov. 2022

    2 SeitenPSC02

    Cessation of Acorn Care and Education Limited as a person with significant control on 23. Nov. 2022

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2021

    27 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2020

    27 SeitenAA

    Ernennung von Mr Chris Duffy als Sekretär am 06. Nov. 2020

    2 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von FOSTERING SOLUTIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BENNETT, Alison
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Sekretär
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    303541440001
    BARCLAY, Simon Timothy
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Geschäftsführer
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    EnglandBritishDirector234364480001
    CHRISTIE, Stephen James
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Geschäftsführer
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    EnglandBritishDirector252091590001
    EDWARDS, Ryan David
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Geschäftsführer
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    EnglandBritishCfo261281630001
    WEBB, Lynn Mary
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Geschäftsführer
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    EnglandBritishRegional Director242258480001
    BHOTE, Sanaya Homi
    Sycamore House
    Devonshire Farm 84 Aylesbury Road
    HP22 5DL Bierton
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Sycamore House
    Devonshire Farm 84 Aylesbury Road
    HP22 5DL Bierton
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director72716110006
    CROGHAN, Mark Arnold
    58 Woodland Rise
    N10 3UJ London
    Sekretär
    58 Woodland Rise
    N10 3UJ London
    BritishFinance Director68865900002
    CUFFE, Michelle
    35 Grange Road
    FY8 2BW Lytham St. Annes
    Lancashire
    Sekretär
    35 Grange Road
    FY8 2BW Lytham St. Annes
    Lancashire
    British70186120002
    DUFFY, Chris
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Sekretär
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    276569590001
    LECKY, Helen Elizabeth
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Sekretär
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    192764950001
    NAPIER-FENNING, William
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    England
    Sekretär
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    England
    171691490001
    RWL REGISTRARS LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    Bevollmächtigter Sekretär
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    900007870001
    ANDERSON, Iain James
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    EnglandBritishChief Executive229331730001
    BHOTE, Sanaya Homi
    Sycamore House
    Devonshire Farm 84 Aylesbury Road
    HP22 5DL Bierton
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Sycamore House
    Devonshire Farm 84 Aylesbury Road
    HP22 5DL Bierton
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director72716110006
    COOKE, Richard John
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Geschäftsführer
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    EnglandBritishDirector208372080001
    CROGHAN, Mark Arnold
    58 Woodland Rise
    N10 3UJ London
    Geschäftsführer
    58 Woodland Rise
    N10 3UJ London
    EnglandBritishFinance Director68865900002
    CUFFE, Michelle
    35 Grange Road
    FY8 2BW Lytham St. Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    35 Grange Road
    FY8 2BW Lytham St. Annes
    Lancashire
    EnglandBritishDirector Of Operations70186120002
    DOHERTY, Hilary Sara
    19 Hardcastle Gardens
    BL2 4NZ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    19 Hardcastle Gardens
    BL2 4NZ Bolton
    Lancashire
    BritishManaging Director70186110001
    EDWARDS, Ryan David
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director (Chartered Accountant)261281630001
    HOLT, Antony Vincent
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    EnglandBritishChartered Accountant190351400001
    HUTCHISON, Isabella Mary
    71 Cowley Road
    UB8 2AE Uxbridge
    Frays Court
    Middlesex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    71 Cowley Road
    UB8 2AE Uxbridge
    Frays Court
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director239615640001
    JANET, Jean-Luc Emmanuel
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Geschäftsführer
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    EnglandFrenchCfo171688520002
    JOHNSON, David William
    14 Royle Avenue
    SK13 7RD Glossop
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    14 Royle Avenue
    SK13 7RD Glossop
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector96898150003
    LEATHERBARROW, David Jon
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Geschäftsführer
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    EnglandBritishGroup Chief Executive Officer135618280010
    MACDONALD, Natalie-Jane Anne, Dr
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Merchants Place
    River Street
    BL2 1BX Bolton
    1
    Lancashire
    EnglandScottishCeo190121340001
    MCNEANY, Kevin Joseph
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    32 Bramhall Park Road
    Bramhall
    SK7 3JN Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director2299150001
    PAGE, Stephen Robert
    Oak Tree House
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Oak Tree House
    Berry Lane
    WD3 5EY Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector257896700001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FOSTERING SOLUTIONS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    23. Nov. 2022
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer07879023
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Acorn Care And Education Limited
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    06. Apr. 2016
    Spa Road
    BL1 4AG Bolton
    Atria
    England
    Ja
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland/Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 1985
    RegistrierungsortRegistered With The Registrar Of Companies For England And Wales
    Registrierungsnummer05019430
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat FOSTERING SOLUTIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 08. Feb. 2024
    Geliefert am 15. Feb. 2024
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All current and future real property (except for any excluded property) and intellectual property (except for any excluded assets) owned by the company, in each case as specified (and defined) in the security accession deed registered by this form MR01 (the "deed"). For more details please refer to the deed.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Kroll Trustee Services Limited (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2024Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 25. Sept. 2019
    Geliefert am 03. Okt. 2019
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    N/A.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lucid Trustee Services Limited (As Security Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 25. Jan. 2024Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 08. Sept. 2016
    Geliefert am 14. Sept. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Except for any restricted land, all current and future material land and other land and current and future intellectual property (except for any restricted ip) and the specified intellectual property owned by the company, in each case as defined in the deed of accession and charge registered by this form MR01 (the "deed") and including, amongst others, trademarks numbered 3157247, 3158344 and 2539560 and the domain names 'www.heathfarm.org' and 'www.heathfarmschool.org'. For more details please refer to the deed.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Aug. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 03. Sept. 2014
    Geliefert am 11. Sept. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ge Corporate Finance Bank Sas, London Branch (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 11. Sept. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 17. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 08. Aug. 2011
    Geliefert am 16. Aug. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged account with account number 53684776 and sort code 20-04-68, and the deposit. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 08. Aug. 2011
    Geliefert am 16. Aug. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from pathway care group limited or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The charged account with account number 73408949 and sort code 20-65-82, and the deposit. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmatory debenture relating to a debenture dated 18 january 2010
    Erstellt am 08. Aug. 2011
    Geliefert am 12. Aug. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Group debenture
    Erstellt am 18. Jan. 2010
    Geliefert am 23. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Sept. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed
    Erstellt am 30. Apr. 2009
    Geliefert am 09. Mai 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,100.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Deposit account at national westminster bank PLC london street norwich.
    Berechtigte Personen
    • Peter Colby Commercials Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental deed
    Erstellt am 14. Aug. 2007
    Geliefert am 23. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent and Trustee for the Other Finance Parties
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed
    Erstellt am 13. Apr. 2007
    Geliefert am 30. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent and Trustee for the Other Finance Parties
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A supplemental deed
    Erstellt am 22. März 2007
    Geliefert am 05. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent and Trustee for the Other Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 05. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed
    Erstellt am 02. März 2007
    Geliefert am 21. März 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All estate, rights, interests, assets and title in any f/h or l/h property inclu. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 21. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A supplemental deed
    Erstellt am 21. Juli 2006
    Geliefert am 02. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 15. Feb. 2006
    Geliefert am 03. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent of and Security Trustee for the Other Finance Parties(The Agent)
    Transaktionen
    • 03. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 24. Jan. 2005
    Geliefert am 26. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0