PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED

PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04008909
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis24. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB am 23. Nov. 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. Nov. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Dez. 2011

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Juni 2012

    Kapitalaufstellung am 06. Juni 2012

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 24. Dez. 2010

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 24. Dez. 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    1 SeitenAD02

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Brian Watt am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für David Graham Paine am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Andrew John Jackson am 05. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Robert Michael Hannigan am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 24. Dez. 2008

    8 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Paolo Alonzi am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten353

    Wer sind die Geschäftsführer von PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALONZI, Paolo
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Sekretär
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Italian113225330001
    HANNIGAN, Robert Michael
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Geschäftsführer
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish81510590004
    JACKSON, Andrew John
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Geschäftsführer
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish83130180001
    PAINE, David Graham
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Geschäftsführer
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    ScotlandBritish79124040001
    WATT, Mark Brian
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    Geschäftsführer
    George Street
    EH2 2LL Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish85845500002
    CATTERALL, Nicola Jane
    Old Stonelaws House
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Sekretär
    Old Stonelaws House
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    British94975930001
    EVANS, Michael
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    Sekretär
    Willowtyne
    Victoria Road
    EH41 4DJ Haddington
    East Lothian
    British98652120001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Sekretär
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    MAHENDRA, Myron Murugendra
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    Sekretär
    9 Wellesley Road
    Chiswick
    W4 4BS London
    British62660140005
    REITH, Julie Katharine
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    Flat 3f2 47 Brunswick Road
    EH7 5PD Edinburgh
    Midlothian
    British112039220001
    TABERNER, Susan
    9 Hillside
    BL1 5DT Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    9 Hillside
    BL1 5DT Bolton
    Lancashire
    British96933410001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    St James's Buildings, 79 Oxford Street
    M1 6FR Manchester
    Sekretär
    The Britannia Suite
    St James's Buildings, 79 Oxford Street
    M1 6FR Manchester
    83758610001
    ALONZI, Paolo
    20 Rattray Grove
    EH10 5TL Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    20 Rattray Grove
    EH10 5TL Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomItalian113225330001
    BARRY, Desmond Joseph William
    9 Tiffany Close
    RG41 3BN Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Tiffany Close
    RG41 3BN Wokingham
    Berkshire
    British27098090001
    EARLY, John Dalton
    Flat 510 Middle Warehouse
    Castle Quay Chester Road
    M15 4NT Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Flat 510 Middle Warehouse
    Castle Quay Chester Road
    M15 4NT Manchester
    Lancashire
    British4150930005
    FRITH, Brian
    Chapelle Des Landes
    Le Mont Des Landes
    JE3 6DJ St Martin
    Jersey
    Geschäftsführer
    Chapelle Des Landes
    Le Mont Des Landes
    JE3 6DJ St Martin
    Jersey
    JerseyBritish72410440001
    JOHNSON, Andrew William
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Fulford Farm
    Culworth
    OX17 2HL Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish68089410003
    MCGUIRE, Martin Anton
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    4 Gilmour Road
    EH16 5NF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish46513600001
    MELHUISH, Richard Marcus
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Roundel
    Buncton Lane, Bolney
    RH17 5RE Haywards Heath
    West Sussex
    British83530000001
    O'BRIEN, Daniel Terence
    47 Willowmead Drive
    Prestbury
    SK10 4DD Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    47 Willowmead Drive
    Prestbury
    SK10 4DD Macclesfield
    Cheshire
    British52052530001
    RUSSO, Onofrio
    8 Stormont Road
    N6 4NL London
    Geschäftsführer
    8 Stormont Road
    N6 4NL London
    Italian53349910001
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Sandiway House
    Hartford
    CW8 2YA Northwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Sandiway House
    Hartford
    CW8 2YA Northwich
    Cheshire
    32732300001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite
    Lauren Court
    M33 2AF Wharf Road
    Sale
    Greater Manchester
    900018550001

    Hat PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each relevant company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first legal mortgage (1) all the property and (2) all estates or interests in any f/h or l/h property now or hereafter belonging to that chargor; the l/h land k/a burger king, lostock lane, bamber bridge, preston, t/n LA891842 and l/h land k/a b&q premises, lostock lane, bamber bridge, preston, t/n LA870380. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of each relevant company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first legal mortgage (1) all the property and (2) all estates or interests in any f/h or l/h property now or hereafter belonging to that chargor; the l/h land k/a burger king, lostock lane, bamber bridge, preston, t/n LA891842 and l/h land k/a b&q premises, lostock lane, bamber bridge, preston, t/n LA870380. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 2002
    Geliefert am 07. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The leasehold properties known as the burger king premises and the b & q premises.
    Berechtigte Personen
    • Primequota Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2001
    Geliefert am 22. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the leasehold land known as the burger king site lostock lane bamber bridge preston lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over collateral warranties
    Erstellt am 05. Feb. 2001
    Geliefert am 07. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the benefit of the company's interest in the eight collateral warranties relating to the development of a retail warehouse at bamber bridge preston lancashire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over development agreement
    Erstellt am 23. Aug. 2000
    Geliefert am 05. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the benefit of the company's interest in two development agreements dated 30/6/2000,as defined,with all rights,titles and benefits thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over agreement for lease
    Erstellt am 23. Aug. 2000
    Geliefert am 05. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the benefit of the company's interest in the two agreements dated 3/4/98 and 13/6/2000,as defined,with all rights,titles,benefits and interests thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Aug. 2000
    Geliefert am 05. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold land comprised in a lease dated 8/6/2000 known as b and q site,lostock lane,bamber bridge,preston,lancs. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Aug. 2000
    Geliefert am 05. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PRIMEQUOTA (BAMBER BRIDGE 2000) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2012Beginn der Liquidation
    07. Apr. 2014Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praktiker
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Praktiker
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0